H.& S.OPENSHAW LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéH.& S.OPENSHAW LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00516501
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de H.& S.OPENSHAW LIMITED ?

    • (5138) /

    Où se situe H.& S.OPENSHAW LIMITED ?

    Adresse du siège social
    19 Copse Road
    FY7 6RP Fleetwood
    Lancashire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de H.& S.OPENSHAW LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour H.& S.OPENSHAW LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 07 févr. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Paul Gower en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable actuelle prolongée du 31 janv. 2011 au 30 juin 2011

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 4 57 Sandgate Street London England SE15 1LE United Kingdom le 04 janv. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Paul Matthew Gower en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 déc. 2010

    • Capital: GBP 3,362,614
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Toby Baxendale en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Taylor Foods Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Unit a15/a19 New Covent Garden Market 9 Elms London SW8 5EE le 10 nov. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Toby Oliver James Baxendale le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Andrew Oswald le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Taylor Foods Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH02

    Comptes annuels établis au 28 mars 2009

    26 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de H.& S.OPENSHAW LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OSWALD, Stephen Andrew
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    Secrétaire
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    BritishAccountant129688190001
    OSWALD, Stephen Andrew
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    Administrateur
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    EnglandBritishAccountant129688190001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    Secrétaire
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    BritishDirector112657600001
    HOSKER, Peter Benjamin
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    BritishFinance Director116270530001
    KAY, Sandra Patricia
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    BritishFishmonger7721770002
    BATESON, Michael Jonathan
    33 Springhead Mills
    Springhead Road
    BD22 7RZ Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    33 Springhead Mills
    Springhead Road
    BD22 7RZ Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director84494860001
    BAXENDALE, Toby Oliver James
    Ayot Bury
    AL6 9BG Ayot St Peter
    Hertfordshire
    Administrateur
    Ayot Bury
    AL6 9BG Ayot St Peter
    Hertfordshire
    United KingdomBritishEntrepreneur107950400001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    Administrateur
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    United KingdomBritishDirector151680990001
    FITTON, Jeremy Rossler, Mr.
    Waystead Close
    Kingsmead
    CW9 8NN Northwich
    2
    Cheshire
    Administrateur
    Waystead Close
    Kingsmead
    CW9 8NN Northwich
    2
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director132712400001
    GOWER, Paul Matthew
    Copse Road
    FY7 6RP Fleetwood
    19
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Copse Road
    FY7 6RP Fleetwood
    19
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector41943830006
    HOSKER, Peter Benjamin
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    BritishFinance Director116270530001
    KAY, Peter Dale
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Administrateur
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    BritishFishmonger7721780002
    KAY, Sandra Patricia
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    BritishFishmonger7721770002
    KNOWLES, Raymond
    520 St Helens Road
    BL3 3SJ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    520 St Helens Road
    BL3 3SJ Bolton
    Lancashire
    BritishFishmonger17154510001
    LAWTON, Mark John
    7 Cambrian Way
    Ewloe
    CH5 3RE Deeside
    Clwyd
    Administrateur
    7 Cambrian Way
    Ewloe
    CH5 3RE Deeside
    Clwyd
    United KingdomBritishOperations Director134828320001
    MEDLICOTT, Nigel Gerald
    25 Eden Street
    Astley Bridge
    BL1 6NL Bolton
    Administrateur
    25 Eden Street
    Astley Bridge
    BL1 6NL Bolton
    BritishFishmonger17154490003
    OWEN, Geoffrey Frank
    29 Queens Place
    Summerseat
    BL9 5PH Bury
    Lancashire
    Administrateur
    29 Queens Place
    Summerseat
    BL9 5PH Bury
    Lancashire
    BritishManager52422420002
    PARNELL, Christine
    1 Redshaw Avenue
    Turton Heights
    BL2 3FL Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    1 Redshaw Avenue
    Turton Heights
    BL2 3FL Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishFinance Director17154500003
    WESTON, Leo George
    6 Ashfield Road
    WA15 9QJ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    6 Ashfield Road
    WA15 9QJ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director74534820006
    WOODWARD, Jeremy Alan
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Administrateur
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector57016650004
    TAYLOR FOODS LIMITED
    New Covent Garden Market
    Nine Elms
    SW8 5EE London
    A15-A19
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    New Covent Garden Market
    Nine Elms
    SW8 5EE London
    A15-A19
    England
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3795013
    140220750001

    H.& S.OPENSHAW LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 03 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 03 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 juil. 2009
    Livré le 08 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 21 avr. 2009
    Livré le 29 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re: h & s openshaw limited and numbered 00777608 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a fishermans wharf mile st bolton. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 17 nov. 2004
    Livré le 19 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fisherman's wharf nile st bolton t/no: GM499696. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 13 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 13 oct. 2004
    Livré le 20 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 oct. 2004
    Livré le 20 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 mars 1989
    Livré le 16 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h land together with the buildings erected thereon fronting to nile street bolton greater manchester. Fixed charge over all movable plant mac hinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 janv. 1982
    Livré le 29 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transactions
    • 29 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 26 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0