COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED

COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00517895
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED01 nov. 201801 nov. 2018
    F&C MANAGEMENT LIMITED19 avr. 200119 avr. 2001
    FOREIGN & COLONIAL MANAGEMENT LIMITED28 mars 198428 mars 1984
    F. & C. MANAGEMENT LIMITED27 mars 195327 mars 1953

    Quels sont les derniers comptes de COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au22 avr. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation06 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au22 avr. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mrs Anne Olayinka en tant que secrétaire le 08 déc. 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michelle Nurse en tant que secrétaire le 08 déc. 2025

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    42 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 avr. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr William Davies en tant qu'administrateur le 24 janv. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rachel Danae Burgin en tant que secrétaire le 11 oct. 2024

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Michelle Nurse en tant que secrétaire le 11 oct. 2024

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Adrian Watts en tant que directeur le 30 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    43 pagesAA

    Deuxième dépôt pour la nomination de Mr Frederic Marie Pierre Mouchel en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Nomination de Mr Frederic Marie Pierre Mouchel en tant qu'administrateur le 30 avr. 2024

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    20 mai 2024Clarification A second filed AP01 was registered on 20/05/2024.

    Cessation de la nomination de Philip John Doel en tant que directeur le 30 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 22 avr. 2024

    3 pagesRP04CS01

    22/04/24 Statement of Capital gbp 62331742

    6 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    29 avr. 2024Clarification A second filed CS01 (Statement of Capital and Shareholder Information) was registered on 29/04/2024.

    État du capital après une attribution d'actions au 14 déc. 2023

    • Capital: GBP 62,331,742
    3 pagesSH01

    Nomination de Mr Michaela Caroline Jackson en tant qu'administrateur le 20 déc. 2023

    2 pagesAP01

    Modification des détails de Columbia Threadneedle Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 déc. 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Exchange House Primrose Street London EC2A 2NY à Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AG le 11 déc. 2023

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    56 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 avr. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 20 mars 2023

    • Capital: GBP 57,331,742
    3 pagesSH01

    Cessation de la nomination de Stuart James Woodyatt en tant que directeur le 28 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 oct. 2022 au 31 déc. 2022

    1 pagesAA01

    Modification des détails de Bmo Am Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2022

    2 pagesPSC05

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bmo asset management LIMITED\certificate issued on 01/07/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 juil. 2022

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Qui sont les dirigeants de COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OLAYINKA, Anne
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Secrétaire
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    343511080001
    DAVIES, William
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    EnglandBritish262239770001
    JACKSON, Michaela Caroline
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    EnglandBritish268520010001
    LOGAN, David
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    EnglandBritish114696050003
    MOUCHEL, Frederic Marie Pierre
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    LuxembourgFrench285536040001
    BENNETT, Tracey Anne
    Willow Brook
    27 Woodhurst Lane
    RH8 9HN Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    Willow Brook
    27 Woodhurst Lane
    RH8 9HN Oxted
    Surrey
    British93189890001
    BOTCHWAY, Denette
    Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2NY London
    Secrétaire
    Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2NY London
    250230860001
    BURGIN, Rachel Danae
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Secrétaire
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    289680720001
    CLARKE, William Theodore
    Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2NY London
    Secrétaire
    Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2NY London
    255776900001
    DONKIN, Robert George
    11 Cottenham Drive
    Wimbledon
    SW20 0TD London
    Secrétaire
    11 Cottenham Drive
    Wimbledon
    SW20 0TD London
    British7767070002
    HARDING, David
    26 Melbury Close
    BR7 5ET Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    26 Melbury Close
    BR7 5ET Chislehurst
    Kent
    British75759470001
    LAM, Katherine
    Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2NY London
    Secrétaire
    Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2NY London
    274592190001
    NURSE, Michelle
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Secrétaire
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    328228900001
    POTTER, Hugh Neil
    65 Marlborough Crescent
    Riverhead
    TN13 2HL Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    65 Marlborough Crescent
    Riverhead
    TN13 2HL Sevenoaks
    Kent
    British26969550001
    BMO ASSET MANAGEMENT (HOLDINGS) PLC
    7a Nightingale Way
    EH3 9EG Edinburgh
    6th Floor, Quartermile 4
    Scotland
    Secrétaire
    7a Nightingale Way
    EH3 9EG Edinburgh
    6th Floor, Quartermile 4
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC073508
    597700029
    BMO ASSET MANAGEMENT (HOLDINGS) PLC
    7a Nightingale Way
    EH3 9EG Edinburgh
    6th Floor, Quartermile 4
    Scotland
    Secrétaire
    7a Nightingale Way
    EH3 9EG Edinburgh
    6th Floor, Quartermile 4
    Scotland
    597700029
    BALK, Thomas
    55 Cliveden Road
    SW19 3RD London
    Administrateur
    55 Cliveden Road
    SW19 3RD London
    German57282870001
    BALK, Thomas
    55 Cliveden Road
    SW19 3RD London
    Administrateur
    55 Cliveden Road
    SW19 3RD London
    German57282870001
    BANERJI, Arnab Kumar, Dr
    The Spinney
    Little Gaddesden
    HP4 1PE Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Spinney
    Little Gaddesden
    HP4 1PE Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74039440001
    BARKER, Andrew Charles
    130 Priory Lane
    Roehampton
    SW15 5JP London
    Administrateur
    130 Priory Lane
    Roehampton
    SW15 5JP London
    EnglandBritish12011070001
    BARKER, Kevin Raymond
    20 Wraglings
    CM23 5TB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 Wraglings
    CM23 5TB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British41115990001
    BELL, Timothy Mark
    Netherby Kimpton Road
    AL6 9NN Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    Netherby Kimpton Road
    AL6 9NN Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish16120900001
    BOXFORD, Michael John
    70 Limerston Street
    SW10 0HJ London
    Administrateur
    70 Limerston Street
    SW10 0HJ London
    EnglandBritish6227190001
    BROCCARDO, Anthony John
    Dene Lodge
    16 Eaton Park Road
    KT11 2JH Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Dene Lodge
    16 Eaton Park Road
    KT11 2JH Cobham
    Surrey
    British77492940001
    BROOKE, Francis George Windham, Sir
    65 Sterndale Road
    W14 0HU London
    Administrateur
    65 Sterndale Road
    W14 0HU London
    EnglandIrish42697160001
    CAMERON, Colin Roger
    16 Thornwood Drive
    PA11 3JQ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    16 Thornwood Drive
    PA11 3JQ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British68235100001
    CARTER, Howard
    Apartment 39
    36 Chapter Street
    SW1P 4NS London
    Administrateur
    Apartment 39
    36 Chapter Street
    SW1P 4NS London
    British41699360006
    CHILDS, Philip John Elphinstone
    20 Briarwood Road
    SW4 9PX London
    Administrateur
    20 Briarwood Road
    SW4 9PX London
    British8725400002
    COLE, Peter Trevillian
    7 Greenfinch Close
    RG45 6TZ Crowthorne
    Berkshire
    Administrateur
    7 Greenfinch Close
    RG45 6TZ Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritish169053940001
    DAVIS, Alan John Mytton
    Fantails
    Little Hill
    RH20 2PU West Chiltington
    West Sussex
    Administrateur
    Fantails
    Little Hill
    RH20 2PU West Chiltington
    West Sussex
    British24944460001
    DAWSON, Oliver Naimby
    12 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    12 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British5403020001
    DE BEUS, Dick Johan
    Machtegaal 79
    3962 Tk
    Wijk Bij Duurstead
    The Netherlands
    Administrateur
    Machtegaal 79
    3962 Tk
    Wijk Bij Duurstead
    The Netherlands
    Dutch96072580001
    DE FIGUEIREDO RIBEIRO, Fernando Jorge Filomeno
    Rua Prof Queiroz Veloso
    Lote F7
    FOREIGN Lisbon
    1600 658
    Portugal
    Administrateur
    Rua Prof Queiroz Veloso
    Lote F7
    FOREIGN Lisbon
    1600 658
    Portugal
    Portuguese77966010001
    DOEL, Philip John
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    EnglandBritish267193920001
    DOLBEAR, Stephen William Ernest
    6 Woodville Place
    Molewood Road
    SG14 3NX Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Woodville Place
    Molewood Road
    SG14 3NX Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish50436930001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COLUMBIA THREADNEEDLE MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Columbia Threadneedle Holdings Limited
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    06 avr. 2016
    78 Cannon Street
    EC4N 6AG London
    Cannon Place
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies
    Numéro d'enregistrement2355196
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0