ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00521510
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    Adresse du siège social
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RYAN UTILITY SERVICES LIMITED20 nov. 200020 nov. 2000
    D.J. RYAN & SONS LIMITED07 juil. 195307 juil. 1953

    Quels sont les derniers comptes de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2009
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2010
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 oct. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation31 oct. 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Lee James Mills en tant que directeur le 28 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que secrétaire le 28 sept. 2018

    2 pagesTM02

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Andrew Wilkins en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 oct. 2009

    État du capital au 22 oct. 2009

    • Capital: GBP 1,449,628
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    05 déc. 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a
    Annotations
    DateAnnotation
    05 déc. 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    legacy

    1 pages287

    legacy

    11 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a
    Annotations
    DateAnnotation
    05 déc. 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    15 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COFFEY, Stephanie Helen
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    British81328280002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Secrétaire
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Secrétaire
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Secrétaire
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    British101833160001
    STONES, Michael John
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    British68468490001
    ARMSTRONG, Neil Patrick
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Irish104897110001
    BROOKES, Philip
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    Administrateur
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89559990001
    BROWN, David Robertson
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    Administrateur
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    United KingdomBritish39067610002
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish11806560001
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Administrateur
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    DARBYSHIRE, John Peter
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    Administrateur
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    British69930320002
    FOX, Kenneth
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish15540580001
    FRASER, Richard
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    Administrateur
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish79090001
    GREENHALGH, Donald
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    Administrateur
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    British47084170002
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Administrateur
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    British53010640001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Administrateur
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Administrateur
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    LANSOM, Stewart Paul
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    Administrateur
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    British79070008
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Administrateur
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LAWLESS, Dennis Arthur
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    British46658890003
    LEACH, William Anthony
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    Administrateur
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    British66732560001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Administrateur
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    EnglandBritish101833160001
    MEMMOTT, Robert William
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British109306950001
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    ROWAN, Michael William
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    British72210350002
    RYAN, Daniel Joseph
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    British1472220001
    RYAN, John Timothy Anthony
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    British39428900001
    RYAN, Michael Bernard
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    British779240001
    SIMCOCK, Barry
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    Administrateur
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    British74253700001
    WILKINS, Andrew Michael
    PR25
    Administrateur
    PR25
    United KingdomBritish125411390001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007

    ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattels mortgage
    Créé le 05 sept. 2001
    Livré le 05 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattles plant machinery, 16 compressor & generator systems, 2 x computer servers (for further details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 05 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 12 févr. 1992
    Livré le 21 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises situate in station road pembroke dyfed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1992
    Livré le 05 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of rough hey road preston lancashire t/n la 585346.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1992
    Livré le 05 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north east side of rough hey road, preston, lancashire. T/n la 525 287.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1992
    Livré le 05 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All those premises known as longridge foundry, inglewhite road, (formerly higher lane) longridge, lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 janv. 1992
    Livré le 05 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Please see doc form M395 reference M198C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 05 avr. 1991
    Livré le 16 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 172590.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance whereof are set out on form 395 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 16 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 24 janv. 1990
    Livré le 08 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future includin book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 août 1988
    Livré le 01 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises situated off rough hey road, preston.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 avr. 1988
    Livré le 14 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north east side of rough hey road preston.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 14 déc. 1971
    Livré le 22 déc. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and premises at longridge foundry, longridge in the county of lancaster with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1971Enregistrement d'une charge
    • 10 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0