PREPARED FOODS GROUP LIMITED

PREPARED FOODS GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREPARED FOODS GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00523009
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    • Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10890) / Industries manufacturières

    Où se situe PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Innovation Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6UW Gallows Hill
    Warwick
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOOKER PREPARED FOODS GROUP LIMITED13 janv. 199713 janv. 1997
    W.A.TURNER LIMITED25 août 195325 août 1953

    Quels sont les derniers comptes de PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2013
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2013
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au02 janv. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation16 janv. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2012

    État du capital au 11 avr. 2012

    • Capital: GBP 8,100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 mars 2011

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 27 mars 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael John Russell le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2009 au 31 mars 2010

    3 pagesAA01

    Comptes établis au 27 déc. 2008

    8 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 29 déc. 2007

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 déc. 2006

    8 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    9 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 01 janv. 2005

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PREPARED FOODS GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RUSSELL, Michael John
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    British48183050001
    RUSSELL, Michael John
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish48183050001
    COATES, Philip Edward
    1 Finch Lane
    Harvington
    WR11 5DQ Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    1 Finch Lane
    Harvington
    WR11 5DQ Evesham
    Worcestershire
    British47902910001
    PLYTE, Mark Edward
    49 Summerheath Road
    BN27 3DR Hailsham
    East Sussex
    Secrétaire
    49 Summerheath Road
    BN27 3DR Hailsham
    East Sussex
    British37417370001
    WHILEY, Graham Leonard
    Cordoba
    21 Bradley Drive
    ME10 1RB Sittingbourne
    Kent
    Secrétaire
    Cordoba
    21 Bradley Drive
    ME10 1RB Sittingbourne
    Kent
    British61634170001
    ABBOTT, David Charles
    9 Countryside
    Braunston
    NN11 7JU Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    9 Countryside
    Braunston
    NN11 7JU Daventry
    Northamptonshire
    British61848490001
    ASHWORTH, Paul Francis
    4 Cambridge Park
    TW1 2PF Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    4 Cambridge Park
    TW1 2PF Twickenham
    Middlesex
    British41740830001
    COATES, Philip Edward
    1 Finch Lane
    Harvington
    WR11 5DQ Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    1 Finch Lane
    Harvington
    WR11 5DQ Evesham
    Worcestershire
    British47902910001
    GREENACRE, Melvyn Walter
    28 The Gill
    Pembury
    TN2 4DL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    28 The Gill
    Pembury
    TN2 4DL Tunbridge Wells
    Kent
    British16847180001
    HUNTER, Nigel John
    Manor Farm 128 Green Street
    TW16 6QJ Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Manor Farm 128 Green Street
    TW16 6QJ Sunbury On Thames
    Middlesex
    United KingdomBritish45026040001
    LANGFORD, Michael Rodney
    The Orchards School Lane
    Colsterworth
    NG33 5NW Grantham
    Lincolnshire
    Uk
    Administrateur
    The Orchards School Lane
    Colsterworth
    NG33 5NW Grantham
    Lincolnshire
    Uk
    British48961920001
    MCLELLAN, Roger
    Appledore House
    2 Stace Close, Beacon Oak Road
    TN30 6RP Tenterden
    Kent
    Administrateur
    Appledore House
    2 Stace Close, Beacon Oak Road
    TN30 6RP Tenterden
    Kent
    British113718700001
    PLYTE, Mark Edward
    49 Summerheath Road
    BN27 3DR Hailsham
    East Sussex
    Administrateur
    49 Summerheath Road
    BN27 3DR Hailsham
    East Sussex
    British37417370001
    PRICE, Stephen
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish73146560001
    ROBERTS, Mark Duncan
    94 Ruxley Lane
    Ewell
    KT19 0HY Epsom
    Surrey
    Administrateur
    94 Ruxley Lane
    Ewell
    KT19 0HY Epsom
    Surrey
    British36027030001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001
    STEENHOLDT, Steen
    Brookhill
    Ravensthorpe Road East Haddon
    NN6 8BY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Brookhill
    Ravensthorpe Road East Haddon
    NN6 8BY Northampton
    Northamptonshire
    Danish16451370001
    TATE, James
    13 Williams Bristow Road
    CV3 5LN Coventry
    Administrateur
    13 Williams Bristow Road
    CV3 5LN Coventry
    British79591810001
    THOMSON, George
    17 Blakelaw Road
    NE66 1AZ Alnwick
    Northumberland
    Administrateur
    17 Blakelaw Road
    NE66 1AZ Alnwick
    Northumberland
    EnglandBritish70118650001
    TURNER, Kevin
    1 Skippers Hill
    Criers Lane
    TN20 6HR Five Ashes
    East Sussex
    Administrateur
    1 Skippers Hill
    Criers Lane
    TN20 6HR Five Ashes
    East Sussex
    British85665400001
    WALL, Peter William
    1 Heath Way
    Heathfield Manor
    CW6 9HQ Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    1 Heath Way
    Heathfield Manor
    CW6 9HQ Tarporley
    Cheshire
    British40946400001
    WHILEY, Graham Leonard
    Cordoba
    21 Bradley Drive
    ME10 1RB Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    Cordoba
    21 Bradley Drive
    ME10 1RB Sittingbourne
    Kent
    British61634170001

    PREPARED FOODS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third party debenture
    Créé le 14 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to any of the secured parties. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land and buildings to the east of broadwater lane tunbridge wells, kent. F/h t/no K828945. Unit 29 castle park ind. Estates, flint, CH6 5XA, f/h CYM35875. Factory, no.1 Land on the north west side of cornhill close, lodge way, northampton f/h t/no HN16610. (For further property charged please refer to the form 395).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Agent")
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 sept. 1998
    Livré le 25 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the debenture
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage l/h land and buildings at coquet industrial park amble northumberland. L/h t/n-ND106720 and all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery from time to time on the further property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co. Limitedas Security Trustee
    Transactions
    • 25 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 19 mai 1997
    Livré le 06 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company formerly known as booker prepared foods group limited covenants that it will pay to the security trustee (as defined) all moneys,obligations and liabilities due owing or incurred by it to the finance parties (as defined) or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) when the same become due for payment or discharge; and irrevocably and unconditionally guarantees: the due performance by the parent (as defined) and each of the other members of the group (as defined) of all its obligations under or pursuant to the finance documents to which it is a party; and the payment of all moneys and discharge of all liabilities due to the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents by (x) each other company (as defined) and by (y) any other present or future subsidiary of the parent or of any company
    Brèves mentions
    1) block 1H and 2H,west kent cold storage estate,sevenoaks,kent;2) bays 7 & 8 block h west kent cold storage estate,rye lane,dunton green,sevenoaks,kent;3) unit 22 eldon way,paddock wood,tunbridge wells,kent.for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co.Limited
    Transactions
    • 06 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 juil. 1982
    Livré le 26 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & premises at east side of broadwater lane, tunbridge wells kent title no. K208653.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank LTD
    Transactions
    • 26 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 18 janv. 1973
    Livré le 24 janv. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/P on the east side of broadwater lane, tunbridge wells together with all machinery fixtures therein or thereon (see doc 46 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1973Enregistrement d'une charge
    • 01 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0