FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00525559 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | LIQ13 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Clair Louise Marshall en tant que directeur le 29 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS le 05 sept. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification de London and Manchester Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 août 2017 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Friends Life Fpl Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 août 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rowan Hostler en tant que secrétaire le 24 mars 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Rowan Tracy Hostler en tant qu'administrateur le 24 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Rowan Hostler en tant que secrétaire le 24 mars 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Friends Life Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 17 mars 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Clair Louise Marshall en tant qu'administrateur le 16 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew David Carr en tant que directeur le 16 janv. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Rowley Rose en tant qu'administrateur le 16 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Charles Paykel en tant que directeur le 16 janv. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 38 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Conor Martin O'neill en tant que directeur le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Stephen Moss en tant que directeur le 30 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Secretariat Friends Life 2nd Floor, One New Change London England EC4M 9EF England à Wellington Row York YO90 1WR | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTLER, Rowan Tracy | Administrateur | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 201266610001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Administrateur | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| HERBERT, Anthony James | Secrétaire | 21 Tite Street SW3 4JT London | British | 29028830004 | ||||||||||
| HITCHON, Mary Elizabeth | Secrétaire | 50 Montagu Square W1H 1TH London | British | 144659590001 | ||||||||||
| HOSTLER, Rowan | Secrétaire | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | 228706870001 | |||||||||||
| RICHARDSON, Ian David Lea | Secrétaire | Gatehouse Farm Dinedor SE1 3RF Hereford | British | 73820300001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Ian David Lea | Secrétaire | Gatehouse Farm Dinedor SE1 3RF Hereford | British | 73820300001 | ||||||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Secrétaire | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | British | 67168210001 | ||||||||||
| WALLWORK, Janet Irwin | Secrétaire | 18 Blenheim Gardens KT2 7BW Kingston Upon Thames Surrey | British | 32917080003 | ||||||||||
| WALLWORK, Janet Irwin | Secrétaire | 18 Blenheim Gardens KT2 7BW Kingston Upon Thames Surrey | British | 32917080003 | ||||||||||
| WEBSTER, John Dudley | Secrétaire | 10 Merrydown Way BR7 5RS Chislehurst Kent | British | 457110001 | ||||||||||
| FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey |
| 154752160001 | ||||||||||
| BARLOW, Paul James | Administrateur | Chantry House 44 Chantry View Road GU1 3XT Guildford Surrey | England | British | 85924720001 | |||||||||
| BLACK, James Masson | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 172334880001 | |||||||||
| BOOTH, Andrew Patterson | Administrateur | Glendower House 48a Cossington Road, Sileby LE12 7RS Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 82631040001 | |||||||||
| BOURKE, Evelyn Brigid | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | Irish,British | 247998930001 | |||||||||
| CARR, Andrew David | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 182546040001 | |||||||||
| CHAPMAN, Stephen James | Administrateur | 3 Walnut Tree Court Congresbury BS49 5EN Bristol | United Kingdom | British | 124822510001 | |||||||||
| CHEESEMAN, David Richard | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | England | British | 132416500001 | |||||||||
| FAULKNER, Anthony | Administrateur | 7 Weston Close Upton Grey RG25 2RX Basingstoke Hampshire | British | 457090001 | ||||||||||
| GALLOWAY, Richard William | Administrateur | Shandon Dormans Park RH19 2NQ East Grinstead West Sussex | British | 8013540002 | ||||||||||
| HARRISON-DEES, Geoffrey | Administrateur | Portland House Rickling Green CB11 3YG Saffron Walden Essex | British | 8041690001 | ||||||||||
| HYNAM, David Emmanuel | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | England | British | 92485410001 | |||||||||
| J'AFARI-PAK, Lindsay Clare | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 155016370001 | |||||||||
| LOWTHER, Sean William | Administrateur | 23 Scantleberry Close BS16 6DQ Bristol | United Kingdom | British | 210466940001 | |||||||||
| MARKHAM, Geoffrey Alan | Administrateur | Pennywell House Bradden NN12 8ED Towcester Northamptonshire | British | 62320350001 | ||||||||||
| MARSHALL, Clair Louise | Administrateur | YO90 1WR York Wellington Row United Kingdom | United Kingdom | British | 200178890001 | |||||||||
| MOORE, John Desmond | Administrateur | Cambera 5 Stanshalls Drive Felton BS40 9UW Bristol | British | 71987380001 | ||||||||||
| MOSS, Jonathan Stephen | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 172135620001 | |||||||||
| NICHOLLS, John Michael | Administrateur | 25 Starling Lane Cuffley EN6 4JX Potters Bar Hertfordshire | England | United Kingdom | 457100001 | |||||||||
| O'NEILL, Conor Martin | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 194342160001 | |||||||||
| OSBORNE, John Michael | Administrateur | 3 Garden Close Halton HP22 5PE Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 7904180001 | |||||||||
| PAINTER, Jeffrey William | Administrateur | Enali 4 Julian Close Sneyd Park BS9 1JX Bristol | British | 45800130001 | ||||||||||
| PARRIS, Stephen Michael | Administrateur | 81 Wentworth Drive MK41 8QD Bedford Bedfordshire | England | British | 28404670001 | |||||||||
| PARSONS, Andrew Mark | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 121609240001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Manchester Group Limited | 04 août 2017 | RH4 1QA Dorking Pixham End Surrey United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Friends Life Fpl Limited | 06 avr. 2016 | RH4 1QA Dorking Pixham End Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
FRIENDS LIFE STAFF SCHEMES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0