AL REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAL REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00531301
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AL REALISATIONS LIMITED ?

    • Vente au détail de textiles en magasin spécialisé (47510) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de meubles, luminaires et articles similaires (autres que les instruments de musique ou les partitions) en magasin spécialisé (47599) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé (47710) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail par correspondance ou par Internet (47910) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe AL REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    FRP ADVISORY TRADING LIMITED
    2nd Floor, 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AL REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAURA ASHLEY LIMITED31 mars 195431 mars 1954

    Quels sont les derniers comptes de AL REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2020
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AL REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 nov. 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 déc. 2020
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 nov. 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour AL REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2024

    23 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2023

    29 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2022

    36 pagesLIQ03

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Qui sont les dirigeants de AL REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AGBEDE, Olayinka Olufunlayo
    22 Riverside Walk
    The Alders
    BR4 9PZ West Wickham
    Kent
    Secrétaire
    22 Riverside Walk
    The Alders
    BR4 9PZ West Wickham
    Kent
    BritishAss Company Sec96102890001
    COOK, David Robert
    33 Saint Paul Street
    N1 7DJ Islington
    London
    Secrétaire
    33 Saint Paul Street
    N1 7DJ Islington
    London
    BritishChief Financial Officer205194920001
    FRASER, Alison
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    181815490001
    GWILT, Jonathan
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    231532070001
    HARVEY, Patricia Jane
    Broadview Firle Road
    BN25 2HU Seaford
    East Sussex
    Secrétaire
    Broadview Firle Road
    BN25 2HU Seaford
    East Sussex
    British18756830003
    HO, Kien Mun
    Bagleys Lane
    Fulham
    SW6 2QA London
    27
    Secrétaire
    Bagleys Lane
    Fulham
    SW6 2QA London
    27
    British146252360001
    HOQUE, Faizul
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    199709390001
    MANTZ, Ann Elizabeth
    21 Four Wents
    KT11 2NE Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    21 Four Wents
    KT11 2NE Cobham
    Surrey
    British37441550001
    MAVANI, Sagar Avinash
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    252019720001
    NAVAREDNAM, Rebecca Annapillai
    Royal College Street
    NW1 9NL London
    26 Foster Court
    Secrétaire
    Royal College Street
    NW1 9NL London
    26 Foster Court
    MalaysianChief Finan.Officer131169120001
    ONG, Angela Chwee Peng
    27 Bagleys Lane
    Fulham
    SW6 2QA London
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    Fulham
    SW6 2QA London
    MalaysianAccountant113926610001
    TEO, Kai Xiang
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    172133840001
    UJOODIA, Jawaharlal
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Secrétaire
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    262817870001
    ANGLIM, Sean Thomas
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Administrateur
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    EnglandIrishDirector146269100004
    BARBER, Jonathan Stephen
    12 Heather Close
    New Haw
    KT15 3PF Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    12 Heather Close
    New Haw
    KT15 3PF Weybridge
    Surrey
    BritishChartered Accountant53719390001
    BARRETT, Clive George
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Administrateur
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    UkAustralianJoint Chief Operating Officer116148810003
    COHEN, Miriam Basha
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    Administrateur
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    AmericanDirector Of Design & Buying46716300002
    COOK, David Robert
    33 Saint Paul Street
    N1 7DJ Islington
    London
    Administrateur
    33 Saint Paul Street
    N1 7DJ Islington
    London
    EnglandBritishFinance Director205194920001
    COTTER, Stephen Anthony
    Bracken
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    Bracken
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritishGroup Director Retailer78750100001
    EGAN, Victoria
    56 Lincoln House
    Basil Street
    SW3 1AW London
    Administrateur
    56 Lincoln House
    Basil Street
    SW3 1AW London
    FilipinoCompany Director58548050002
    GRANT, Stephen
    18 Mayfield Avenue
    W4 1PW London
    Administrateur
    18 Mayfield Avenue
    W4 1PW London
    BritishGroup Director68747030001
    HART, Keith Alisdaire
    14 Ashen Green
    Great Shelford
    CB2 5EY Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    14 Ashen Green
    Great Shelford
    CB2 5EY Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishAccountant15036830001
    HASLEHURST, Geoffrey Peter
    Rivermead
    Avenue Road
    SL6 1UG Maidenhead
    Berks
    Administrateur
    Rivermead
    Avenue Road
    SL6 1UG Maidenhead
    Berks
    United KingdomBritishGroup Finance Director1103560002
    HENG, Robert Fook Hee
    54 Beechcroft Avenue
    KT3 3EE New Malden
    Surrey
    Administrateur
    54 Beechcroft Avenue
    KT3 3EE New Malden
    Surrey
    MalaysianChief Operating Officer64381060003
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    Little Wood Wood End
    SL7 2HW Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Wood Wood End
    SL7 2HW Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director57637410001
    HINDLEY, Richard
    6 The Hollies
    RH8 0RN Oxted
    Surrey
    Administrateur
    6 The Hollies
    RH8 0RN Oxted
    Surrey
    BritishCommercial Director117496570001
    HO, Kien Mun
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Administrateur
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    UkMalaysianChief Financial Officer165315360001
    HOARE, David Alexander
    40 Chepstow Place
    W2 4TA London
    Administrateur
    40 Chepstow Place
    W2 4TA London
    United KingdomBritishDirector10920000001
    IVERSON, Ann
    3 Mallord Street
    SW3 6DT London
    Administrateur
    3 Mallord Street
    SW3 6DT London
    AmericanChief Executive39733470004
    KALOYIROU, Nicos
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Administrateur
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    EnglandBritishDirector135083000002
    KINGSBURY, Michael Norman
    12 Rosebery Gardens
    W13 0HD London
    Administrateur
    12 Rosebery Gardens
    W13 0HD London
    United KingdomBritishDirector86506500001
    LINCOLN, Denise Elizabeth
    Rooks Hill Old Farmhouse Rooks Hill
    Bramley
    GU5 0LX Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Rooks Hill Old Farmhouse Rooks Hill
    Bramley
    GU5 0LX Guildford
    Surrey
    BritishDirector54894450001
    MANNING, Patricia Fraser
    10 Lower Addison Gardens
    W14 8BQ London
    Administrateur
    10 Lower Addison Gardens
    W14 8BQ London
    AmericanMarketing Director29572270001
    MAVANI, Sagar Avinash
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    Administrateur
    27 Bagleys Lane
    London
    SW6 2QA Fulham
    EnglandBritishChief Financial Officer265671490001
    MAXMIN, Hiram James, Dr
    110 Marlborough Street
    Boston
    Massachusetts 02116
    Usa
    Administrateur
    110 Marlborough Street
    Boston
    Massachusetts 02116
    Usa
    BritishChief Executive Officer31753000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AL REALISATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Laura Ashley Holdings Plc
    Bagleys Lane
    SW6 2QA London
    27
    England
    06 avr. 2016
    Bagleys Lane
    SW6 2QA London
    27
    England
    Non
    Forme juridiqueListed Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement01012631
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    AL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 déc. 2019
    Livré le 13 déc. 2019
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 13 déc. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 oct. 2019
    Livré le 18 oct. 2019
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 18 oct. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 août 2019
    Livré le 21 août 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land. See clause 3.1(a) of the debenture that creates a legal mortgage over the land (as defined in the debenture) set out in schedule 2, including the following:. Name of chargor description of land freehold/leasehold title number. Laura ashley limited land lying on the south of heol vastre, vastre industrial estate, newtown freehold WA632557. Also see clause 3.1(b) of the debenture that creates a fixed charge over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire to or in any other land, other than a leasehold interest in land.. Further, see clause 3.2 of the debenture that creates a fixed charge (to the extent it is not prohibited from doing so under the relevant lease agreement) over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire in any leasehold interest in land.. Intellectual property. See clause 3.9 of the debenture which creates a fixed charge over all intellectual property rights (as defined in the debenture), including the following:. Trade mark proprietor country classes status app. No reg. Date reg. No international reg. No.. Ashley laura ashley limited united kingdom 14,20,21,26,27,35,36,39,40,42,43,44,45 registered 2310478 10-oct-2003 2310478 n/A. Cook's kitchen laura ashley limited united kingdom 3,4,5,8,9,18,21,24,25 registered UK00003093976 22-may-2015 UK00003093976 n/A. Laura ashley laura ashley limited united kingdom 2,3,11,16,18,19,20,21,24,25,26,27 registered 1231150 25-may-1990 1231150 n/A. Please also see schedule 4 within the debenture (this schedule includes further charged intellectual property rights).
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 21 août 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 13 oct. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 30 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land lying on the south east of heol vastre vastre industrial estate newtown t/n WA632557.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra-Commerce Bank Berhad (The Bank)
    Transactions
    • 30 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 30 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land at vastre industrial estate newtown t/n WA400923.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra-Commerce Bank Berhad (The Bank)
    Transactions
    • 30 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 30 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land lying on the east side of heol vastre industrial estate newtown t/n WA295292.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra-Commerce Bank Berhad (The Bank)
    Transactions
    • 30 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 30 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the north side of heol vastre newtown t/n WA420060.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra-Commerce Bank Berhad (The Bank)
    Transactions
    • 30 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 30 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the north side of heol vastre newtown t/n WA420065.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra-Commerce Bank Berhad (The Bank)
    Transactions
    • 30 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 mars 2003
    Livré le 26 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (With the exception of the property referred to as unit d vastre industrial park in the term properties). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra Commerce Bank Berhad
    Transactions
    • 26 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 18 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra Commerce Bank Berhad
    Transactions
    • 18 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 02 août 2002
    Livré le 06 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    This document was updated against this company in error and should have gone against the record of chelsea stores limited 3123019
    Brèves mentions
    This document was updated against this company in error and should have gone against the record of chelsea stores limited 3123019.
    Personnes ayant droit
    • N/A
    Transactions
    • 06 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge by way of legal mortgage
    Créé le 28 févr. 2002
    Livré le 01 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 6 interlink road bardon leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Bumiputra-Commerce Bank Berhad
    Transactions
    • 01 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 04 janv. 2002
    Livré le 05 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a unit 6 interlink park bardon leicestershire part t/no lt 253604.
    Personnes ayant droit
    • Wilson Bowden Developments Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 10 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and to each and every assigned contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 10 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 10 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and laura ashley manufacturing B.V. (together the chargors) to any of the security trustee and the banks (as defined) under each of the financing documents on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the marks and to their other intellectual property rights and all related agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 10 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trademark security agreement
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 10 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All trademarks trade names trademark licences all reissues all goodwill of the business and all proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee and Agent for Each of the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 10 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 avr. 2000
    Livré le 25 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents including the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trademark security agreement
    Créé le 23 déc. 1997
    Livré le 06 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or lara ashley manufacturing B.V. to the chargee under each of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    The benefit of all the trademark collateral.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia (The "Agent"), Acting as Agent and Arranger for the Banks
    Transactions
    • 06 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 22 déc. 1997
    Livré le 06 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or laura ashley manufacturing B.V. (the "chargors") to the chargee under each of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    All property, revenue proceeds, rights, intellectual property rights, floating charge on undertaking and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia (The "Agent"), as Agent and Arranger, for the Banks
    Transactions
    • 06 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 19 juin 1990
    Livré le 05 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the UK facilities agreement, the us facilities agreement the security trust deed and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    All and whole the sub-lease of subjects at 84-90 buchanan street glasgow t/n- gla 26805.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limitedfor Itself and Trustee for the Beneficiories
    Transactions
    • 05 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security trust deed,
    Créé le 13 juin 1990
    Livré le 22 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    (See form M395, ref M777C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 22 juin 1990Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 07 juin 1985
    Livré le 27 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold 256/258 regent street london W1 and mezzanine floor at 19/20 argyll street, london W1.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1985
    Livré le 25 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H unit. A vastre industrial estate newtown powys.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1985
    Livré le 25 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjacent to unit A. vastre industrial estate newtown powys.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1985Enregistrement d'une charge

    AL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 mars 2020Administration started
    30 mars 2021Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Paul David Allen
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Rachael Wilkinson
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    practitioner
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    2
    DateType
    30 mars 2021Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Allen
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0