AL REALISATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | AL REALISATIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00531301 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AL REALISATIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | FRP ADVISORY TRADING LIMITED 2nd Floor, 110 Cannon Street EC4N 6EU London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AL REALISATIONS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2019 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2020 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2018 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AL REALISATIONS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 03 nov. 2020 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 déc. 2020 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 03 nov. 2019 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour AL REALISATIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2024 | 23 pages | LIQ03 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2023 | 29 pages | LIQ03 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2022 | 36 pages | LIQ03 | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 5 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 5 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 5 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 5 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||
Qui sont les dirigeants de AL REALISATIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBEDE, Olayinka Olufunlayo | Secrétaire | 22 Riverside Walk The Alders BR4 9PZ West Wickham Kent | British | Ass Company Sec | 96102890001 | |||||
COOK, David Robert | Secrétaire | 33 Saint Paul Street N1 7DJ Islington London | British | Chief Financial Officer | 205194920001 | |||||
FRASER, Alison | Secrétaire | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | 181815490001 | |||||||
GWILT, Jonathan | Secrétaire | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | 231532070001 | |||||||
HARVEY, Patricia Jane | Secrétaire | Broadview Firle Road BN25 2HU Seaford East Sussex | British | 18756830003 | ||||||
HO, Kien Mun | Secrétaire | Bagleys Lane Fulham SW6 2QA London 27 | British | 146252360001 | ||||||
HOQUE, Faizul | Secrétaire | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | 199709390001 | |||||||
MANTZ, Ann Elizabeth | Secrétaire | 21 Four Wents KT11 2NE Cobham Surrey | British | 37441550001 | ||||||
MAVANI, Sagar Avinash | Secrétaire | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | 252019720001 | |||||||
NAVAREDNAM, Rebecca Annapillai | Secrétaire | Royal College Street NW1 9NL London 26 Foster Court | Malaysian | Chief Finan.Officer | 131169120001 | |||||
ONG, Angela Chwee Peng | Secrétaire | 27 Bagleys Lane Fulham SW6 2QA London | Malaysian | Accountant | 113926610001 | |||||
TEO, Kai Xiang | Secrétaire | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | 172133840001 | |||||||
UJOODIA, Jawaharlal | Secrétaire | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | 262817870001 | |||||||
ANGLIM, Sean Thomas | Administrateur | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | England | Irish | Director | 146269100004 | ||||
BARBER, Jonathan Stephen | Administrateur | 12 Heather Close New Haw KT15 3PF Weybridge Surrey | British | Chartered Accountant | 53719390001 | |||||
BARRETT, Clive George | Administrateur | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | Uk | Australian | Joint Chief Operating Officer | 116148810003 | ||||
COHEN, Miriam Basha | Administrateur | 53 Elystan Place SW3 3JY London | American | Director Of Design & Buying | 46716300002 | |||||
COOK, David Robert | Administrateur | 33 Saint Paul Street N1 7DJ Islington London | England | British | Finance Director | 205194920001 | ||||
COTTER, Stephen Anthony | Administrateur | Bracken Plantation Road LU7 3HT Leighton Buzzard Bedfordshire | England | British | Group Director Retailer | 78750100001 | ||||
EGAN, Victoria | Administrateur | 56 Lincoln House Basil Street SW3 1AW London | Filipino | Company Director | 58548050002 | |||||
GRANT, Stephen | Administrateur | 18 Mayfield Avenue W4 1PW London | British | Group Director | 68747030001 | |||||
HART, Keith Alisdaire | Administrateur | 14 Ashen Green Great Shelford CB2 5EY Cambridge Cambridgeshire | British | Accountant | 15036830001 | |||||
HASLEHURST, Geoffrey Peter | Administrateur | Rivermead Avenue Road SL6 1UG Maidenhead Berks | United Kingdom | British | Group Finance Director | 1103560002 | ||||
HENG, Robert Fook Hee | Administrateur | 54 Beechcroft Avenue KT3 3EE New Malden Surrey | Malaysian | Chief Operating Officer | 64381060003 | |||||
HIGGINSON, Andrew Thomas | Administrateur | Little Wood Wood End SL7 2HW Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 57637410001 | ||||
HINDLEY, Richard | Administrateur | 6 The Hollies RH8 0RN Oxted Surrey | British | Commercial Director | 117496570001 | |||||
HO, Kien Mun | Administrateur | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | Uk | Malaysian | Chief Financial Officer | 165315360001 | ||||
HOARE, David Alexander | Administrateur | 40 Chepstow Place W2 4TA London | United Kingdom | British | Director | 10920000001 | ||||
IVERSON, Ann | Administrateur | 3 Mallord Street SW3 6DT London | American | Chief Executive | 39733470004 | |||||
KALOYIROU, Nicos | Administrateur | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | England | British | Director | 135083000002 | ||||
KINGSBURY, Michael Norman | Administrateur | 12 Rosebery Gardens W13 0HD London | United Kingdom | British | Director | 86506500001 | ||||
LINCOLN, Denise Elizabeth | Administrateur | Rooks Hill Old Farmhouse Rooks Hill Bramley GU5 0LX Guildford Surrey | British | Director | 54894450001 | |||||
MANNING, Patricia Fraser | Administrateur | 10 Lower Addison Gardens W14 8BQ London | American | Marketing Director | 29572270001 | |||||
MAVANI, Sagar Avinash | Administrateur | 27 Bagleys Lane London SW6 2QA Fulham | England | British | Chief Financial Officer | 265671490001 | ||||
MAXMIN, Hiram James, Dr | Administrateur | 110 Marlborough Street Boston Massachusetts 02116 Usa | British | Chief Executive Officer | 31753000001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AL REALISATIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Ashley Holdings Plc | 06 avr. 2016 | Bagleys Lane SW6 2QA London 27 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
AL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 11 déc. 2019 Livré le 13 déc. 2019 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 16 oct. 2019 Livré le 18 oct. 2019 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 19 août 2019 Livré le 21 août 2019 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land. See clause 3.1(a) of the debenture that creates a legal mortgage over the land (as defined in the debenture) set out in schedule 2, including the following:. Name of chargor description of land freehold/leasehold title number. Laura ashley limited land lying on the south of heol vastre, vastre industrial estate, newtown freehold WA632557. Also see clause 3.1(b) of the debenture that creates a fixed charge over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire to or in any other land, other than a leasehold interest in land.. Further, see clause 3.2 of the debenture that creates a fixed charge (to the extent it is not prohibited from doing so under the relevant lease agreement) over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire in any leasehold interest in land.. Intellectual property. See clause 3.9 of the debenture which creates a fixed charge over all intellectual property rights (as defined in the debenture), including the following:. Trade mark proprietor country classes status app. No reg. Date reg. No international reg. No.. Ashley laura ashley limited united kingdom 14,20,21,26,27,35,36,39,40,42,43,44,45 registered 2310478 10-oct-2003 2310478 n/A. Cook's kitchen laura ashley limited united kingdom 3,4,5,8,9,18,21,24,25 registered UK00003093976 22-may-2015 UK00003093976 n/A. Laura ashley laura ashley limited united kingdom 2,3,11,16,18,19,20,21,24,25,26,27 registered 1231150 25-may-1990 1231150 n/A. Please also see schedule 4 within the debenture (this schedule includes further charged intellectual property rights). La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 06 oct. 2017 Livré le 13 oct. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 déc. 2004 Livré le 30 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land lying on the south east of heol vastre vastre industrial estate newtown t/n WA632557. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 déc. 2004 Livré le 30 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land at vastre industrial estate newtown t/n WA400923. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 déc. 2004 Livré le 30 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land lying on the east side of heol vastre industrial estate newtown t/n WA295292. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 déc. 2004 Livré le 30 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land and buildings on the north side of heol vastre newtown t/n WA420060. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 déc. 2004 Livré le 30 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land and buildings on the north side of heol vastre newtown t/n WA420065. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 12 mars 2003 Livré le 26 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions (With the exception of the property referred to as unit d vastre industrial park in the term properties). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 nov. 2002 Livré le 18 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 02 août 2002 Livré le 06 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti This document was updated against this company in error and should have gone against the record of chelsea stores limited 3123019 | |
Brèves mentions This document was updated against this company in error and should have gone against the record of chelsea stores limited 3123019. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge by way of legal mortgage | Créé le 28 févr. 2002 Livré le 01 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H property k/a unit 6 interlink road bardon leicestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 04 janv. 2002 Livré le 05 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Property k/a unit 6 interlink park bardon leicestershire part t/no lt 253604. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 28 juil. 2000 Livré le 10 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions All right title benefit and interest in and to each and every assigned contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security deed | Créé le 28 juil. 2000 Livré le 10 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and laura ashley manufacturing B.V. (together the chargors) to any of the security trustee and the banks (as defined) under each of the financing documents on any account whatsoever | |
Brèves mentions All right title and interest in and to the marks and to their other intellectual property rights and all related agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Trademark security agreement | Créé le 28 juil. 2000 Livré le 10 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) on any account whatsoever | |
Brèves mentions All trademarks trade names trademark licences all reissues all goodwill of the business and all proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 12 avr. 2000 Livré le 25 avr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents including the debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Trademark security agreement | Créé le 23 déc. 1997 Livré le 06 janv. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or lara ashley manufacturing B.V. to the chargee under each of the finance documents (as defined) | |
Brèves mentions The benefit of all the trademark collateral.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security deed | Créé le 22 déc. 1997 Livré le 06 janv. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or laura ashley manufacturing B.V. (the "chargors") to the chargee under each of the finance documents (as defined) | |
Brèves mentions All property, revenue proceeds, rights, intellectual property rights, floating charge on undertaking and assets.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 19 juin 1990 Livré le 05 juil. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the UK facilities agreement, the us facilities agreement the security trust deed and deeds supplemental thereto. | |
Brèves mentions All and whole the sub-lease of subjects at 84-90 buchanan street glasgow t/n- gla 26805. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security trust deed, | Créé le 13 juin 1990 Livré le 22 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents (as defined) | |
Brèves mentions (See form M395, ref M777C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 07 juin 1985 Livré le 27 juin 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/Hold 256/258 regent street london W1 and mezzanine floor at 19/20 argyll street, london W1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 janv. 1985 Livré le 25 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H unit. A vastre industrial estate newtown powys. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 janv. 1985 Livré le 25 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land adjacent to unit A. vastre industrial estate newtown powys. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
AL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In administration |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0