G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED

G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG. WHITAKER REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00531573
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED ?

    • (5190) /
    • (7415) /

    Où se situe G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    G.WHITAKER & CO.LIMITED02 avr. 195402 avr. 1954

    Quels sont les derniers comptes de G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 févr. 2010

    8 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 oct. 2009

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2009

    26 pages4.68

    Certificat de changement de nom

    Company name changed G.whitaker & co.LIMITED\certificate issued on 27/08/08
    2 pagesCERTNM

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 avr. 2008

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages287

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2007

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2006

    15 pagesAA

    legacy

    9 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEPWORTH, Ian Richard
    7 West Croft
    Addingham
    LS29 0SP Ilkley
    Secrétaire
    7 West Croft
    Addingham
    LS29 0SP Ilkley
    British58840890006
    WHITAKER, Elizabeth Helen
    Winebeck Farm
    Addingham
    LS29 0RF Ilkley
    W Yorks
    Administrateur
    Winebeck Farm
    Addingham
    LS29 0RF Ilkley
    W Yorks
    EnglandBritishDirector20420420001
    WHITAKER, John Brian
    Wine Beck Farm
    Addingham
    LS29 0RF Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wine Beck Farm
    Addingham
    LS29 0RF Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector1547500001
    WHITAKER, Timothy Richard
    28 Parish Ghyll Road
    LS29 9NE Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    28 Parish Ghyll Road
    LS29 9NE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishEngineer62358630002
    GRIFFIN, Allan
    17 Branksome Drive
    Nab Wood
    BD18 4BB Shipley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    17 Branksome Drive
    Nab Wood
    BD18 4BB Shipley
    West Yorkshire
    British51397520001
    WHITAKER, George David
    Willow Brook Moor Lane
    Menston
    LS29 6AP Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Willow Brook Moor Lane
    Menston
    LS29 6AP Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector2995590001
    WHITAKER, Isobel Dorothy
    Willow Brook Moor Lane
    Menston
    LS29 6AP Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Willow Brook Moor Lane
    Menston
    LS29 6AP Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector20389690001

    G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 10 avr. 2003
    Livré le 12 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H oakwood court city road bradford. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 mars 2003
    Livré le 27 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 janv. 1999
    Livré le 29 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Brown, Shipley & Co Limited
    Transactions
    • 29 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 janv. 1999
    Livré le 20 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 janv. 1999
    Livré le 15 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 07 août 1998
    Livré le 20 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations covenants undertakings and agreements and all moneys and liabilities which are now due or hereafter may become due in any currency and in any manner whatsoever from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 15TH july 1998 or under the terms of the charge and also all losses and damages that may be sustained suffered or incurred by the bank arising out of or in connection with any act matter or thing done or omitted to be done by the company under the facility letter or the charge and also interest on the foregoing to the date of payment
    Brèves mentions
    First fixed charge all amounts due owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover under contracts entered into or at any time after the date of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 24 juil. 1996
    Livré le 02 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations, covenants, undertakings and agreements and all moneys and liabilities which are now due or hereafter may become due in any currency and in any manner whatsoever from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 19 july 1996 or under the terms of the charge and also all losses and damages that may be sustained suffered or incurred by the bank arising out of or in connection with any act, matter or thing done or omitted to be done by the company under the facility letter or the charge, and also interest on the foregoing to the date of payment
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all amounts due, owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover under contracts entered into or at any time after the date of the charge to be entered into by the company for the sale of goods on credit terms not exceeding 180 days from the date of despatch or delivery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 18 juil. 1996
    Livré le 02 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 28TH july 1995 or this charge
    Brèves mentions
    The property and rights for the time being comprised in or subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Brown Shipley & Co.LTD.
    Transactions
    • 02 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 01 déc. 1995
    Livré le 08 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations covenants undertakings and agreements and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 9TH november 1995 or under the terms of the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all amounts due owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover under contracts entered into or at any time after the date of the charge to be entered into by the company for the sale of goods on credit terms not exceeding 180 days from the date of despatch or delivery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 18 mars 1994
    Livré le 06 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 22ND february 1994 or under this charge
    Brèves mentions
    All amounts due, owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover under contracts entered into or any time after the date hereof to be entered into by the company for the sale of goods on credit terms not exceeding 180 days from the date of despatch or delivery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 05 mai 1992
    Livré le 21 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 20/3/92 or under the terms of the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all amounts due, owing or payable to the company by buyers on whom the company holds credit risk insurance cover under contracts entered into by the company (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    G. WHITAKER REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2008Commencement of winding up
    18 mai 2010Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Adrian David Allen
    Baker Tilly
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    practitioner
    Baker Tilly
    2 Whitehall Quay
    LS1 4HG Leeds
    Philip Edward Pierce
    Jupiter House The Drive
    Great Warley
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    practitioner
    Jupiter House The Drive
    Great Warley
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0