VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED

VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00535340
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VIBROPLANT LIMITED03 juil. 195403 juil. 1954

    Quels sont les derniers comptes de VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Nomination de Mr Keith John Winstanley en tant qu'administrateur le 01 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Anna Catherine Bielby en tant qu'administrateur le 01 janv. 2024

    2 pagesAP01

    État du capital au 21 déc. 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Cessation de la nomination de Neil Andrew Stothard en tant que directeur le 30 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Sarah Elizabeth Jones en tant que secrétaire le 01 oct. 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Neil Andrew Stothard en tant que secrétaire le 30 sept. 2023

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Sarah Elizabeth
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    314182540001
    BIELBY, Anna Catherine
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish309437440001
    PILKINGTON, Jeremy Frederic George
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish3408250002
    WINSTANLEY, Keith John
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish318037220001
    PARTRIDGE, Neil Russell
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    British43666120001
    STOTHARD, Neil Andrew
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    British40008250003
    SWARBRICK, Rodney Victor
    7 Mulberry Avenue
    Penwortham
    PR1 0LL Preston
    Secrétaire
    7 Mulberry Avenue
    Penwortham
    PR1 0LL Preston
    British44604310001
    WOOLLEY, Eric Ryhs
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    British22806550002
    PARTRIDGE, Neil Russell
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    British43666120001
    STOTHARD, Neil Andrew
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40008250003
    WOOLLEY, Eric Ryhs
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    British22806550002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Otley Road
    Beckwithshaw
    HG3 1UD Harrogate
    Central House
    England
    06 avr. 2016
    Otley Road
    Beckwithshaw
    HG3 1UD Harrogate
    Central House
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement481833
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 30 mars 1998
    Livré le 03 avr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 mars 1982
    Livré le 05 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific eqitable charge over all f/h & l/h properties and or the proceeds of the sale thereof, fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security scottish form
    Créé le 15 mars 1972
    Livré le 29 mars 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A standard security which was presented for registration of sasines on 17TH march 1972 for securing the monies due from fred pilkington and son limited to the chargee secured by a charge dated 13.5.69
    Brèves mentions
    A fixed charge a time floating charge onqueendykes industrial estate broxbourne etc (see doc 43 for details).
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance, Corporation LTD
    Transactions
    • 29 mars 1972Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge effecting substitution of security.
    Créé le 29 nov. 1971
    Livré le 06 déc. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from fred pilkington and son limited to the charge secured by a charge dated 23/5/69
    Brèves mentions
    First fixed charge on freehold property at boblers mill, nottingham, t/n W123063 with landlords fixtures and a first floating charge on the space heating equipment. (See docs 41).
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance, Corporation LTD
    Transactions
    • 06 déc. 1971Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Disposition
    Créé le 17 mars 1969
    Livré le 05 déc. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    17 march 69 disposition which was presened for registration of registered of sasines on 16 sept 69 for securing £39,298.
    Brèves mentions
    2.769 acres of leed property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. (37).
    Personnes ayant droit
    • County Council of West Lothian
    Transactions
    • 05 déc. 1969Enregistrement d'une charge
    Disposition
    Créé le 17 mars 1969
    Livré le 20 oct. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Disposition which was presented for registration at register of sasines on 16 sept. 69 for securing sterling pounds 39298
    Brèves mentions
    2.769 acres of lead property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian.
    Personnes ayant droit
    • County Council of West Lothian
    Transactions
    • 20 oct. 1969Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0