VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00535340 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2023 |
Quels sont les derniers dépôts pour VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Keith John Winstanley en tant qu'administrateur le 01 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Anna Catherine Bielby en tant qu'administrateur le 01 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
État du capital au 21 déc. 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Andrew Stothard en tant que directeur le 30 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Sarah Elizabeth Jones en tant que secrétaire le 01 oct. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Andrew Stothard en tant que secrétaire le 30 sept. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Sarah Elizabeth | Secrétaire | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | 314182540001 | |||||||
| BIELBY, Anna Catherine | Administrateur | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 309437440001 | |||||
| PILKINGTON, Jeremy Frederic George | Administrateur | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 3408250002 | |||||
| WINSTANLEY, Keith John | Administrateur | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 318037220001 | |||||
| PARTRIDGE, Neil Russell | Secrétaire | Cranford Lands Lane HG5 8DH Knaresborough North Yorkshire | British | 43666120001 | ||||||
| STOTHARD, Neil Andrew | Secrétaire | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | British | 40008250003 | ||||||
| SWARBRICK, Rodney Victor | Secrétaire | 7 Mulberry Avenue Penwortham PR1 0LL Preston | British | 44604310001 | ||||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Secrétaire | 8 Hereford Road HG1 2NP Harrogate North Yorkshire | British | 22806550002 | ||||||
| PARTRIDGE, Neil Russell | Administrateur | Cranford Lands Lane HG5 8DH Knaresborough North Yorkshire | British | 43666120001 | ||||||
| STOTHARD, Neil Andrew | Administrateur | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 40008250003 | |||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Administrateur | 8 Hereford Road HG1 2NP Harrogate North Yorkshire | British | 22806550002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vp Plc | 06 avr. 2016 | Otley Road Beckwithshaw HG3 1UD Harrogate Central House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 30 mars 1998 Livré le 03 avr. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 30 mars 1982 Livré le 05 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific eqitable charge over all f/h & l/h properties and or the proceeds of the sale thereof, fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security scottish form | Créé le 15 mars 1972 Livré le 29 mars 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti A standard security which was presented for registration of sasines on 17TH march 1972 for securing the monies due from fred pilkington and son limited to the chargee secured by a charge dated 13.5.69 | |
Brèves mentions A fixed charge a time floating charge onqueendykes industrial estate broxbourne etc (see doc 43 for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental charge effecting substitution of security. | Créé le 29 nov. 1971 Livré le 06 déc. 1971 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from fred pilkington and son limited to the charge secured by a charge dated 23/5/69 | |
Brèves mentions First fixed charge on freehold property at boblers mill, nottingham, t/n W123063 with landlords fixtures and a first floating charge on the space heating equipment. (See docs 41). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Disposition | Créé le 17 mars 1969 Livré le 05 déc. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti 17 march 69 disposition which was presened for registration of registered of sasines on 16 sept 69 for securing £39,298. | |
Brèves mentions 2.769 acres of leed property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. (37). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Disposition | Créé le 17 mars 1969 Livré le 20 oct. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti Disposition which was presented for registration at register of sasines on 16 sept. 69 for securing sterling pounds 39298 | |
Brèves mentions 2.769 acres of lead property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0