HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00544265
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hazlehead
    Crowedge
    S36 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STONEWARE LIMITED05 févr. 195505 févr. 1955

    Quels sont les derniers comptes de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 oct. 2012

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    2 pagesAA

    Nomination de Mr John Sage en tant qu'administrateur le 31 juil. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Calum James Forsyth en tant que directeur le 31 juil. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2011

    État du capital au 26 oct. 2011

    • Capital: GBP 350,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Taylor en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Keith Barker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages403b

    Qui sont les dirigeants de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Paul William
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    Secrétaire
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    British62180340002
    SAGE, John
    Latimer Road
    Cropston
    LE7 7GP Leicester
    19
    United Kingdom
    Administrateur
    Latimer Road
    Cropston
    LE7 7GP Leicester
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish171410140001
    TAYLOR, Paul William
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    Administrateur
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    United KingdomBritish62180340002
    PHILLIPS, Robert Glyn
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    British842980001
    BARKER, Keith Stuart
    12 Tan House Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Greater Manchester
    Administrateur
    12 Tan House Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Greater Manchester
    EnglandBritish110773520001
    BARNETT, Michael David
    26 Brough Road
    South Cave
    HU15 2BX Brough
    North Humberside
    Administrateur
    26 Brough Road
    South Cave
    HU15 2BX Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish102557780001
    BEEVER, Robert Neville
    Dalveen Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Dalveen Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish1646430001
    BIRD, Stephen Clive
    South End Cottage Orleans Road
    TW1 3BL Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    South End Cottage Orleans Road
    TW1 3BL Twickenham
    Middlesex
    British47512480003
    BROSSET, Michel, Dr
    Am Sportplatz 6
    Monheim/Rhein
    D-40789
    Germany
    Administrateur
    Am Sportplatz 6
    Monheim/Rhein
    D-40789
    Germany
    French75143240001
    DOE, Brian
    Whiterails Kington Langley
    SN15 5NS Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Whiterails Kington Langley
    SN15 5NS Chippenham
    Wiltshire
    British30733690001
    FORSYTH, Calum James
    Galloping Lane
    Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse
    GL56 9QT Moreton In Marsh
    The Stables
    Gloucestershire
    Administrateur
    Galloping Lane
    Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse
    GL56 9QT Moreton In Marsh
    The Stables
    Gloucestershire
    EnglandUk172355700002
    GALE, Paul Nicolas
    Ash Cottage
    Upper Wilshaw
    HD7 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ash Cottage
    Upper Wilshaw
    HD7 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    British72881120001
    GORANSSON, Rolf Claes Erik
    Unter Den Ulmen 1
    50968 Koln
    Germany
    Administrateur
    Unter Den Ulmen 1
    50968 Koln
    Germany
    Sweden73403360003
    HASKELL, Peter
    1 Clarel Street
    Penistone
    S30 6AU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    1 Clarel Street
    Penistone
    S30 6AU Sheffield
    South Yorkshire
    British1646450001
    HOUBEN, Philippus Petrus Franciscus Clemens
    Zuider Stationsweg 2d
    2061 He Bloemendaal
    The Netherlands
    Administrateur
    Zuider Stationsweg 2d
    2061 He Bloemendaal
    The Netherlands
    NetherlandsDutch71084460001
    LEMON, David Edward Leonard
    6 Hillcrest Avenue
    South Normanton
    DE55 3NR Alfreton
    Derbyshire
    Administrateur
    6 Hillcrest Avenue
    South Normanton
    DE55 3NR Alfreton
    Derbyshire
    British2649630001
    PHILLIPS, Robert Glyn
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    British842980001
    REDDICK, Terence William
    Shires Rest
    Gainsborough Road
    DN10 5DF Drakeholes
    Administrateur
    Shires Rest
    Gainsborough Road
    DN10 5DF Drakeholes
    British92835860001
    SPRATT, Quentin Rodney
    Orchard Farm
    Brow Lane Antrobus
    CW9 6JY Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Orchard Farm
    Brow Lane Antrobus
    CW9 6JY Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish60606400001
    TAYLOR, Andrew Rankine
    Highfield Hall
    306 Barnsley Road
    WF2 6AX Sandal
    Administrateur
    Highfield Hall
    306 Barnsley Road
    WF2 6AX Sandal
    EnglandBritish158807800001
    THOMPSON, Kenneth
    105 Castle Rock Drive
    LE67 4SE Coalville
    Leicestershire
    Administrateur
    105 Castle Rock Drive
    LE67 4SE Coalville
    Leicestershire
    British1680650001

    HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 sept. 2005
    Livré le 23 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the afforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge,any real property,the charged deposits and all investments,shares and related rights.assignment,the insurances and the assigned deposits.floating charge,undertaking and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V.(As Security Agent)
    Transactions
    • 23 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 oct. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 23 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 avr. 2002
    Livré le 30 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft,London (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 30 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pik debenture
    Créé le 18 avr. 2002
    Livré le 30 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft,London (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 30 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 déc. 1980
    Livré le 13 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,901.18 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the chargeing subsitionery.
    Personnes ayant droit
    • Sachroder Ececutor & Trustee Company Limited
    Transactions
    • 13 janv. 1989Enregistrement d'une charge

    HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 oct. 2013Dissolved on
    18 oct. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0