GENTRA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGENTRA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00544337
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GENTRA LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe GENTRA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GENTRA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROYAL TRUST BANK03 nov. 198603 nov. 1986
    ROYAL TRUST COMPANY OF CANADA (THE)08 févr. 195508 févr. 1955

    Quels sont les derniers comptes de GENTRA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour GENTRA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 févr. 2019 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur P Keith Hyde le 05 déc. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ricky Tang le 05 déc. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    10 pagesAA

    Modification des détails de Gentra Holdings Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 août 2018

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD England à Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW le 03 août 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 24 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    12 pagesAA

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 24 févr. 2016

    22 pagesRP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 avr. 2016

    État du capital au 13 avr. 2016

    • Capital: GBP 123,714,259
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    27 avr. 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 27/04/2016

    Modification des coordonnées du secrétaire Allen Yi le 11 mars 2014

    1 pagesCH03

    Nomination de Ricky Tang en tant qu'administrateur le 08 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bryan Kenneth Davis en tant que directeur le 08 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 18 juil. 2014

    • Capital: GBP 123,714,259
    3 pagesSH01

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Berwin Leighton Paisner Llp, D Hughes Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 9HA à C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD le 25 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 mars 2015

    État du capital au 20 mars 2015

    • Capital: GBP 108,866,959
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GENTRA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    YI, Allen
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    Secrétaire
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    British187547370001
    HYDE, P Keith
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Administrateur
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    CanadaCanadian105505500001
    TANG, Ricky
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Administrateur
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    United StatesCanadian206973950002
    GREGORY, Philip Charles
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    Secrétaire
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    British33287640001
    HYDE, P Keith
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Secrétaire
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Canadian105505500001
    IRONSIDE, Simon Anthony
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    Secrétaire
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    British31215710001
    MOODY, Patricia Joan
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    British5286990001
    MULROY, Kieran Finbarr
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Secrétaire
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Canadian48720010001
    WICKS, Martin Theodore
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    Secrétaire
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    British62800470003
    BARR, Brian Ernest
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    Administrateur
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    British Canadian7708890001
    BRIERLEY, Michael Charles
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    British5287010001
    CAPE, Edmund Andrew
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Administrateur
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Canadian36523210001
    CORNELISSEN, Michael Adriaan
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Administrateur
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Canadian7708900001
    DAVENPORT, Maurice Hopwood
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritish6765160001
    DAVIS, Bryan Kenneth
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    Administrateur
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    CanadaCanadian111671370001
    DONNE, David Lucas
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    Administrateur
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    United KingdomBritish36527200001
    FAIRCHILD, Robert William
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Administrateur
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    BritainBritish16613760002
    FELL, Fraser Matthews
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Canadian36469670001
    FREUND, Michael Walter
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469710001
    GAMBLE, Horace Roy
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British4379420001
    HARKER, William Clinton
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Administrateur
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Canadian22380340003
    HOLBECHE, Philip Leslie
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    Administrateur
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish7708940001
    JOLY, Laurent Maurice
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Administrateur
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Canadian48827400001
    KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Administrateur
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Canadian36228770001
    KIMBALL, Marcus Richard, Lord
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    British7708960001
    LAMBERT, Allen Thomas
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Administrateur
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Canadian7708970001
    LAURIE, Craig J
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Administrateur
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Canadian105152590003
    LOVEGROVE, Philip Albert
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    Administrateur
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    British35568310001
    MACDOUGALL, Hartland Molson
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Administrateur
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Canadian7708980001
    MILLER, James William
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Administrateur
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Canadian34028940001
    PORTER, Michael Andrew
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    British32404350001
    STROYAN, Colin Strathearn Ropner
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    Administrateur
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    United KingdomBritish1866210001
    WALKER, James Barrett
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469780001
    ONTARIO LIMITED
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    Administrateur
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    48719890001
    SURREY INVESTMENTS INCORPORATED
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Administrateur
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    68083360002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GENTRA LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gentra Holdings Company
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    19 avr. 2016
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Unlimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies (England And Wales
    Numéro d'enregistrement02022747
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GENTRA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment
    Créé le 11 nov. 1994
    Livré le 21 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the contract. The sum of £24,000 deposited with barclays finance company (isle of man) limited in the name of gentra limited.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 21 juil. 1994
    Livré le 29 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company to the chargee (as defined in the deed)
    Brèves mentions
    The sum of £952,500 in account no 31538268.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Assurance PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash
    Créé le 13 avr. 1994
    Livré le 14 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the hutton guarantee and/or this charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums deposited in account no. 548-785-5 and any debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Canada (Iom) Limited
    Transactions
    • 14 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 09 mars 1994
    Livré le 24 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the counter-indemnity of even date and/or this agreement
    Brèves mentions
    All of the company's right title benefit and interest in and to the obligations of the mortgagee to make payment of all amounts standing to the credit to the company's deutschmark call deposit account maintained with the mortgagee and designated "royal bank of canada europe limited re: gentra - cash collateral a/c" and in and to all interest arising in connection therewith and all other amounts credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Canada Europe Limited
    Transactions
    • 24 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage sale agreement
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 05 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined)
    Brèves mentions
    The sum of £7,918,194.00 credited to the midland bank PLC of poultry & princes street,london EC2P 2BX, account number 21381679 together with all sums in the future credited to that account and including interest accrued or accruing in the future on the account.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Mortgage Asset No.1 Limited
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 18 juin 1993
    Livré le 05 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the charged assets and by way of floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transactions
    • 05 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental security document
    Créé le 04 juin 1993
    Livré le 22 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the sub-participation agreement (as defined therein)
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all the additional charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transactions
    • 22 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 17 mai 1993
    Livré le 07 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-participation agreement dated 17 may 1993.
    Brèves mentions
    The chargor charges as beneficial owner in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets as defined.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transactions
    • 07 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 07 mai 1993
    Livré le 26 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the sub-participation agreement dated 7 may 1993.
    Brèves mentions
    The chargor as beneficial owner charges in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trustco Limited.
    Transactions
    • 26 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 23 avr. 1993
    Livré le 10 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trustco Limited
    Transactions
    • 10 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 22 avr. 1993
    Livré le 29 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All rights under any additional documents and charged assets...................see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transactions
    • 29 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of amendment
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 29 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For amending the sub-participation agreement dated 7.4.93 (as defined)
    Brèves mentions
    All present and future rights......see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transactions
    • 29 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 07 avr. 1993
    Livré le 22 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the "charged assets" being the loan portfolio and all rights of the company under any additional documents connected with the loan portfolio. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transactions
    • 22 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security document
    Créé le 12 mars 1993
    Livré le 26 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the "charged assets". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transactions
    • 26 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 mars 1986
    Livré le 04 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at eccleshall road, south, sheffield district of s yorks known as blenham nursing home t/n yew 41499. f/h land adjoining the above known as the blenheim lifestyle developments, t/nos. Stk 154003, ywe 41499. f/h land at old whittington chesterfield, derbyshire. F/h land off melbourne ave sheffield district of s yorks, (see doc M151 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Bank (Jersey) Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 31 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0