H.R.P. (EXPORTS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la soci été | H.R.P. (EXPORTS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00544550 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe H.R.P. (EXPORTS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15 Bruntcliffe Avenue Leeds 27 Industrial Estate LS27 0LL Morley Leeds |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de H.R.P. (EXPORTS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour H.R.P. (EXPORTS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Rougham Industrial Estate Rougham Bury St Edmunds Suffolk IP30 9XA à 15 Bruntcliffe Avenue Leeds 27 Industrial Estate Morley Leeds LS27 0LL le 18 févr. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Pilgrim en tant que directeur le 17 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr per Olof Goran Bertland en tant qu'administrateur le 17 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John David Billson en tant qu'administrateur le 17 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Andrej Karlin en tant qu'administrateur le 17 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Pilgrim en tant que secrétaire le 17 nov. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kingsley Wilton Curtis en tant que directeur le 03 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de H.R.P. (EXPORTS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTLAND, Per Olof Goran | Administrateur | Bruntcliffe Avenue Leeds 27 Industrial Estate LS27 0LL Morley 15 Leeds | Sweden | Swedish | 101206670002 | |||||
| BILLSON, John David | Administrateur | Bruntcliffe Avenue Leeds 27 Industrial Estate LS27 0LL Morley 15 Leeds | United Kingdom | British | 203105580001 | |||||
| KARLIN, Simon Andrej | Administrateur | Bruntcliffe Avenue Leeds 27 Industrial Estate LS27 0LL Morley 15 Leeds | Sweden | Swedish | 203104930001 | |||||
| MERRITT, David John | Secrétaire | Sicklesmere House Little Whelnetham Sicklesmere IP30 0BX Bury St Edmunds Suffolk | British | 37762780001 | ||||||
| PILGRIM, Amanda | Secrétaire | Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9XA Bury St. Edmunds Suffolk | British | 56226460002 | ||||||
| SHAND, Richard Edward | Secrétaire | Tibenham Farm Long Row, Tibenham NR16 1PD Norwich Norfolk | British | 67118680001 | ||||||
| ALGER, Thomas Richard | Administrateur | Albany Cottage 8 Oatlands Close KT13 9ED Weybridge Surrey | England | British | 7207600001 | |||||
| CURTIS, Kingsley Wilton | Administrateur | Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9XA Bury St. Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 7207610003 | |||||
| PILGRIM, Amanda | Administrateur | Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9XA Bury St. Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 56226460002 | |||||
| SHAND, Richard Edward | Administrateur | Tibenham Farm Long Row, Tibenham NR16 1PD Norwich Norfolk | England | British | 67118680001 | |||||
| HRP HOLDINGS LIMITED | Administrateur | Rougham Industrial Estate Rougham IP30 9ND Bury St Edmunds Suffolk | 15302760001 |
H.R.P. (EXPORTS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Further guarantee & debenture | Créé le 07 janv. 1982 Livré le 15 janv. 1982 | En cours | Montant garanti All monied due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Charged by the principal deed & further deeds. Undertaking and all property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Further guarantee & debenture | Créé le 19 sept. 1979 Livré le 02 oct. 1979 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company nd/or all or any of the other companies named therein the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All that, property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Further guarantee & debenture | Créé le 16 mai 1975 Livré le 28 mai 1975 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of th e other companies named therein the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All that, property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 21 déc. 1972 Livré le 29 déc. 1972 | En cours | Montant garanti All monied due or to become due from the company and/or all or any of the companies listed in col 1 to the bank. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital. Fixed and floating charge (see doc. 37 for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0