ESSENTRA COMPONENTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ESSENTRA COMPONENTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00547495 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Langford Locks OX5 1HX Kidlington Oxford England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 avr. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Emma Ann Reid le 18 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 33 pages | AA | ||||||||||
legacy | 228 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
Nomination de Martin Whittaker en tant qu'administrateur le 22 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hugues Delcourt en tant que directeur le 06 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 19 déc. 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 18 déc. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ozan Dogan le 15 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 33 pages | AA | ||||||||||
legacy | 199 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Emma Ann Reid en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Scott Morgan Taylor Fawcett en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gabriele Hannen en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ozan Dogan en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Hugues Delcourt en tant qu'administrateur le 31 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott Morgan Taylor Fawcett le 04 oct. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REID, Emma | Secrétaire | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | 283059860001 | |||||||
DOGAN, Ozan | Administrateur | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | United Kingdom | Turkish | Finance Director | 302995890002 | ||||
REID, Emma Ann | Administrateur | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | England | British | Chartered Secretary | 301431190002 | ||||
WHITTAKER, Martin | Administrateur | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | United Kingdom | British | Sales Director | 322654460001 | ||||
EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Secrétaire | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | British | 49678170001 | ||||||
FIELDING, Kelly | Secrétaire | 6 Friars Stile Place TW10 6NL Richmond Surrey | British | 101618800001 | ||||||
GREEN, Jon Michael | Secrétaire | Avebury House 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes | British | 105507950003 | ||||||
HUSSEY, Paul Nicholas | Secrétaire | York House 45 Seymour Street W1H 7JT London Bunzl Plc | British | Solicitor | 28010290009 | |||||
CALLAN, Maurice Simon | Administrateur | Ayres Cottage 71 Bicester Road Long Crendon HP18 9EE Aylesbury Buckinghamshire | British | Company Director | 72172980001 | |||||
COBB, Sarah Louise | Administrateur | Castlebank Milton Road Shipton Under Wychwood OX7 6BD Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Business Systems Director | 57345810001 | ||||
CRUMMETT, Stephen Paul | Administrateur | Avebury House 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes | England | British | Company Director | 177741840001 | ||||
DELCOURT, Hugues | Administrateur | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | France | Belgian | Managing Director | 302995390001 | ||||
DRYDEN, Stephen William | Administrateur | Home Farm Arlescote OX17 1DQ Banbury Oxfordshire | England | British | Finance Director | 47821400004 | ||||
EDWARDS, Martin | Administrateur | Barn Cottage Main Street OX11 0RZ Chilton Oxon | England | British | Accountant | 105433480001 | ||||
FAWCETT, Scott Morgan Taylor | Administrateur | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | England | British | Company Director | 172715420006 | ||||
FISH, Mark | Administrateur | 17 Lydney Park West Bridgford NG2 7TJ Nottingham | British | Company Director | 93400200002 | |||||
GARRATT, Nicholas Mark | Administrateur | 7 Chipperfield Park Road Bloxham OX15 4NX Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 71191020004 | ||||
GOODE, David Stuart | Administrateur | 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House United Kingdom | England | British | Company Director | 262959710001 | ||||
GREGORY, Matthew | Administrateur | London Road AL1 1PL St Albans 180 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Company Director | 70063900003 | ||||
GREGORY, Matthew | Administrateur | 180 London Road AL1 1PL St Albans Hertfordshire | England | British | Director | 70063900003 | ||||
HANNEN, Gabriele | Administrateur | OX5 1HX Kidlington Langford Locks Oxford England | England | British | Accountant | 261761140002 | ||||
HARPER, Mark Jeremy | Administrateur | 2 Orchard View Tithe Lane Clifton OX15 0PU Banbury Oxfordshire | British | Managing Director | 25469330002 | |||||
HARRISON, Richard David | Administrateur | Westbury House Milton Road, Bloxham OX15 4HD Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 64515700002 | ||||
HOLMES, Robert | Administrateur | 11 Pennant Road Burbage LE10 2LA Hinckley Leicestershire | British | Sales Director | 62477650001 | |||||
HYDES, Michael John | Administrateur | 25 Poolfield Drive B91 1SH Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Director | 32606620001 | ||||
IBISON, Mark | Administrateur | Westhorpe Road SL7 1LB Marlow 15 England England | United Kingdom | English | Accountant | 153325500002 | ||||
KIRK, Leonard Mcneil | Administrateur | Avebury House 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes | United Kingdom | British | Company Director | 182727400001 | ||||
MOHIUDDIN, Aamir | Administrateur | 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes Avebury House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 228402830001 | ||||
MORTON, John | Administrateur | 40 Abelwood Road Long Hanborough OX8 8DD Witney Oxfordshire | British | Director | 26866740001 | |||||
PHILLIPS, Grahame Spencer | Administrateur | 31 Stratford Drive Eynsham OX8 1QJ Witney Oxfordshire | British | European Ops Director | 11464110001 | |||||
PURCELL, John Robert | Administrateur | Park Road Combe OX29 8NA Oxon Whittons United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 175155890001 | ||||
PURKIS, Paul Michael | Administrateur | 20 Vanner Road OX8 6PF Witney Oxfordshire | British | Company Director | 45946900001 | |||||
ROBERTSON, Melanie Jane | Administrateur | White Wing Chillingham Court Ascot Road Nuptown RG42 6HR Warfield Berkshire | British | Director | 79071130001 | |||||
ROSS, Hugh Alexander | Administrateur | Avebury House 201-249 Avebury Boulevard MK9 1AU Milton Keynes | England | British | Company Director | 246975310001 | ||||
SOMERVILLE, Andrew Forbes, Dir | Administrateur | 9 Studdridge Court Stokenchurch HP14 3UL High Wycombe Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 45830710001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essentra International Limited | 06 avr. 2016 | Kidlington OX5 1HX Oxford Langford Locks England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ESSENTRA COMPONENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings lying to the south of langford lane kidlington oxfordshire title no on 31746. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land containing 0.26 acres or thereabouts situate near langford lane kidlington oxfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land situate on the south side of langford lane kidlington oxfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land containing 0.068 acres or thereabouts situate near langford lane kidlington oxfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land to the south of langford lane kidlington oxfordshire containing an area of 1.561 acres or thereabouts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land having a frontage to langford lane kidlington oxfordshire of 195 ft 6INS together with building erected thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 1982 Livré le 23 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land to the south of langford lane kidlington oxfordshire containing an area of 1.403 acres or thereabouts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0