ESSENTRA COMPONENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéESSENTRA COMPONENTS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00547495
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits en plastique (22290) / Industries manufacturières

    Où se situe ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Langford Locks
    OX5 1HX Kidlington
    Oxford
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOSS PLASTIC PARTS LIMITED31 juil. 198731 juil. 1987
    ROBERT MOSS PUBLIC LIMITED COMPANY06 avr. 195506 avr. 1955

    Quels sont les derniers comptes de ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mars 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mars 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Emma Ann Reid le 18 nov. 2024

    2 pagesCH01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023

    33 pagesAA

    legacy

    228 pagesPARENT_ACC

    Nomination de Martin Whittaker en tant qu'administrateur le 22 avr. 2024

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Cessation de la nomination de Hugues Delcourt en tant que directeur le 06 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital au 19 déc. 2023

    • Capital: GBP 71,301,798.0
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 18/12/2023
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 18 déc. 2023

    • Capital: GBP 71,301,798
    3 pagesSH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ozan Dogan le 15 nov. 2023

    2 pagesCH01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022

    33 pagesAA

    legacy

    199 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mrs Emma Ann Reid en tant qu'administrateur le 31 mars 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Scott Morgan Taylor Fawcett en tant que directeur le 31 mars 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gabriele Hannen en tant que directeur le 31 mars 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Ozan Dogan en tant qu'administrateur le 31 mars 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Hugues Delcourt en tant qu'administrateur le 31 mars 2023

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott Morgan Taylor Fawcett le 04 oct. 2022

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REID, Emma
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Secrétaire
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    283059860001
    DOGAN, Ozan
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Administrateur
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    United KingdomTurkishFinance Director302995890002
    REID, Emma Ann
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Administrateur
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    EnglandBritishChartered Secretary301431190002
    WHITTAKER, Martin
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Administrateur
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    United KingdomBritishSales Director322654460001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    British49678170001
    FIELDING, Kelly
    6 Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    6 Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    Surrey
    British101618800001
    GREEN, Jon Michael
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Secrétaire
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    British105507950003
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secrétaire
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    BritishSolicitor28010290009
    CALLAN, Maurice Simon
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director72172980001
    COBB, Sarah Louise
    Castlebank
    Milton Road Shipton Under Wychwood
    OX7 6BD Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Castlebank
    Milton Road Shipton Under Wychwood
    OX7 6BD Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishBusiness Systems Director57345810001
    CRUMMETT, Stephen Paul
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Administrateur
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    EnglandBritishCompany Director177741840001
    DELCOURT, Hugues
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Administrateur
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    FranceBelgianManaging Director302995390001
    DRYDEN, Stephen William
    Home Farm
    Arlescote
    OX17 1DQ Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Home Farm
    Arlescote
    OX17 1DQ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishFinance Director47821400004
    EDWARDS, Martin
    Barn Cottage
    Main Street
    OX11 0RZ Chilton
    Oxon
    Administrateur
    Barn Cottage
    Main Street
    OX11 0RZ Chilton
    Oxon
    EnglandBritishAccountant105433480001
    FAWCETT, Scott Morgan Taylor
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Administrateur
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    EnglandBritishCompany Director172715420006
    FISH, Mark
    17 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Administrateur
    17 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    BritishCompany Director93400200002
    GARRATT, Nicholas Mark
    7 Chipperfield Park Road
    Bloxham
    OX15 4NX Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    7 Chipperfield Park Road
    Bloxham
    OX15 4NX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector71191020004
    GOODE, David Stuart
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    Administrateur
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director262959710001
    GREGORY, Matthew
    London Road
    AL1 1PL St Albans
    180
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    London Road
    AL1 1PL St Albans
    180
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director70063900003
    GREGORY, Matthew
    180 London Road
    AL1 1PL St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    180 London Road
    AL1 1PL St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector70063900003
    HANNEN, Gabriele
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    Administrateur
    OX5 1HX Kidlington
    Langford Locks
    Oxford
    England
    EnglandBritishAccountant261761140002
    HARPER, Mark Jeremy
    2 Orchard View
    Tithe Lane Clifton
    OX15 0PU Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    2 Orchard View
    Tithe Lane Clifton
    OX15 0PU Banbury
    Oxfordshire
    BritishManaging Director25469330002
    HARRISON, Richard David
    Westbury House
    Milton Road, Bloxham
    OX15 4HD Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Westbury House
    Milton Road, Bloxham
    OX15 4HD Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director64515700002
    HOLMES, Robert
    11 Pennant Road
    Burbage
    LE10 2LA Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    11 Pennant Road
    Burbage
    LE10 2LA Hinckley
    Leicestershire
    BritishSales Director62477650001
    HYDES, Michael John
    25 Poolfield Drive
    B91 1SH Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    25 Poolfield Drive
    B91 1SH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector32606620001
    IBISON, Mark
    Westhorpe Road
    SL7 1LB Marlow
    15
    England
    England
    Administrateur
    Westhorpe Road
    SL7 1LB Marlow
    15
    England
    England
    United KingdomEnglishAccountant153325500002
    KIRK, Leonard Mcneil
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Administrateur
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    United KingdomBritishCompany Director182727400001
    MOHIUDDIN, Aamir
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    Administrateur
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Avebury House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector228402830001
    MORTON, John
    40 Abelwood Road
    Long Hanborough
    OX8 8DD Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    40 Abelwood Road
    Long Hanborough
    OX8 8DD Witney
    Oxfordshire
    BritishDirector26866740001
    PHILLIPS, Grahame Spencer
    31 Stratford Drive
    Eynsham
    OX8 1QJ Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    31 Stratford Drive
    Eynsham
    OX8 1QJ Witney
    Oxfordshire
    BritishEuropean Ops Director11464110001
    PURCELL, John Robert
    Park Road
    Combe
    OX29 8NA Oxon
    Whittons
    United Kingdom
    Administrateur
    Park Road
    Combe
    OX29 8NA Oxon
    Whittons
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector175155890001
    PURKIS, Paul Michael
    20 Vanner Road
    OX8 6PF Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    20 Vanner Road
    OX8 6PF Witney
    Oxfordshire
    BritishCompany Director45946900001
    ROBERTSON, Melanie Jane
    White Wing Chillingham Court
    Ascot Road Nuptown
    RG42 6HR Warfield
    Berkshire
    Administrateur
    White Wing Chillingham Court
    Ascot Road Nuptown
    RG42 6HR Warfield
    Berkshire
    BritishDirector79071130001
    ROSS, Hugh Alexander
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    Administrateur
    Avebury House
    201-249 Avebury Boulevard
    MK9 1AU Milton Keynes
    EnglandBritishCompany Director246975310001
    SOMERVILLE, Andrew Forbes, Dir
    9 Studdridge Court
    Stokenchurch
    HP14 3UL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Studdridge Court
    Stokenchurch
    HP14 3UL High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant45830710001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ESSENTRA COMPONENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kidlington
    OX5 1HX Oxford
    Langford Locks
    England
    06 avr. 2016
    Kidlington
    OX5 1HX Oxford
    Langford Locks
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01172804
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ESSENTRA COMPONENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings lying to the south of langford lane kidlington oxfordshire title no on 31746.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    • 18 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land containing 0.26 acres or thereabouts situate near langford lane kidlington oxfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate on the south side of langford lane kidlington oxfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land containing 0.068 acres or thereabouts situate near langford lane kidlington oxfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    • 18 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land to the south of langford lane kidlington oxfordshire containing an area of 1.561 acres or thereabouts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land having a frontage to langford lane kidlington oxfordshire of 195 ft 6INS together with building erected thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 1982
    Livré le 23 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land to the south of langford lane kidlington oxfordshire containing an area of 1.403 acres or thereabouts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0