VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00549181
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITISH VITA INVESTMENTS LIMITED13 mai 195513 mai 1955

    Quels sont les derniers comptes de VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian William Robb le 16 juil. 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital au 06 nov. 2020

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    4 pagesSH20

    legacy

    4 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Mohammed Omar Shafi Khan en tant qu'administrateur le 12 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Ian William Robb en tant qu'administrateur le 07 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Mark Cheele en tant que directeur le 31 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Oldham Road Middleton Manchester M24 2DB

    1 pagesAD04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Secrétaire
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement01031815
    110906090002
    O'RIORDAN, Daniel Joseph, Mr.
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish176979900001
    ROBB, Ian William
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish263073080001
    ROUND, Darren Lee
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish100922110001
    SHAFI KHAN, Mohammed Omar
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish239506860001
    HODGES, John
    1a Ashlea Grove
    Grotton
    OL4 4LE Oldham
    Secrétaire
    1a Ashlea Grove
    Grotton
    OL4 4LE Oldham
    British350570001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Secrétaire
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    BHATT, Kanakrai Ramanlal
    Whiteoaks
    Chester Road Mere
    WA16 6LG Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Whiteoaks
    Chester Road Mere
    WA16 6LG Knutsford
    Cheshire
    British33879920001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Administrateur
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish122799590001
    CHEELE, Jonathan Mark
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish127959950003
    DOBSON, Roy
    248 Compstall Road
    Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    248 Compstall Road
    Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Cheshire
    British6930380002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Administrateur
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritish105961550001
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Administrateur
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    British93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    6 Carr Holme Gardens
    Green Lane East Cabus
    PR6 7QH Garstang
    Lancashire
    Administrateur
    6 Carr Holme Gardens
    Green Lane East Cabus
    PR6 7QH Garstang
    Lancashire
    British79273660002
    MAIDEN, Jeremy Kim
    Beech Lawn
    Heath
    WF1 5SL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Beech Lawn
    Heath
    WF1 5SL Wakefield
    West Yorkshire
    British71913700002
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish56093930002
    MCGEE, Robert
    Dale Brow Farm
    61 Macclesfield Road Prestbury
    SK10 4BH Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Dale Brow Farm
    61 Macclesfield Road Prestbury
    SK10 4BH Macclesfield
    Cheshire
    British87945430001
    MELTHAM, John David
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish74570910001
    MENENDEZ, Joseph Henry
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Administrateur
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    UsaAmerican127225800003
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16253240001
    OLIVER, John Lancaster
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    Administrateur
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom116941050001
    SELLERS, Rodney Horrocks
    Stonecroft
    3 Lostock Junction Lane Lostock
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Stonecroft
    3 Lostock Junction Lane Lostock
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    EnglandEnglish53752390002
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish78366970002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Vita (Group) Unlimited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    06 avr. 2016
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Unlimited Company
    Pays d'enregistrementU.K.
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrement871669
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 avr. 2009
    Livré le 01 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent
    Transactions
    • 01 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 août 2005
    Livré le 12 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transactions
    • 12 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 19 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or hereafter standing to the credit of account no.301-018-5548-68-001 With the bank.
    Personnes ayant droit
    • Bank Brussels Lambert
    Transactions
    • 19 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0