NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED

NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00551271
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Exchange House Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WAIN DEVELOPMENTS LIMITED10 févr. 198710 févr. 1987
    BRADLEY PROPERTY COMPANY LIMITED27 mai 198627 mai 1986
    EDWARD PROPERTY CO LIMITED29 juin 195529 juin 1955

    Quels sont les derniers comptes de NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 juil. 2017

    • Capital: GBP 2
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium a/c cancelled 31/05/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 26 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr William Francis Ainscough en tant qu'administrateur le 09 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen John Owen en tant que directeur le 09 mars 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Cedarwood 2 Kelvin Close Birchwood Warrington Cheshire WA3 7PB à Exchange House Kelburn Court Birchwood Warrington WA3 6UT le 19 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2015

    État du capital au 02 nov. 2015

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 oct. 2014

    État du capital au 06 oct. 2014

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2013

    État du capital au 12 nov. 2013

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    13 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 05/07/2012
    RES13
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    10 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TREWEEK, Roger James
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    Secrétaire
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    British73557350001
    AINSCOUGH, William Francis
    Arthog Road
    Hale
    WA15 0LU Altrincham
    38
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Arthog Road
    Hale
    WA15 0LU Altrincham
    38
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor106090700008
    AINSCOUGH, William
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    Administrateur
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    United KingdomBritishCompany Director18332250011
    RIGBY, John Frederick
    Robinholme 13 Spinney Close
    New Longton
    PR4 4JF Preston
    Secrétaire
    Robinholme 13 Spinney Close
    New Longton
    PR4 4JF Preston
    British34760780002
    AINSCOUGH, Eileen Rebecca
    Harrock Hall
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    Harrock Hall
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director26406010001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishSolicitor122926460001
    CASSIDY, John
    5 Oakwood Drive
    Prestbury
    SK10 4HG Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    5 Oakwood Drive
    Prestbury
    SK10 4HG Macclesfield
    Cheshire
    BritishChartered Accountant2643760002
    FRASER, Brian
    39 Kennedy Crescent
    EH33 1DN Tranent
    Lothian
    Administrateur
    39 Kennedy Crescent
    EH33 1DN Tranent
    Lothian
    BritishBanker79811110001
    MOORES, Peter, Sir
    Parbold Hall
    Parbold
    WN8 7TG Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    Parbold Hall
    Parbold
    WN8 7TG Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director1848390001
    OWEN, Stephen John
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    Administrateur
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    United KingdomBritishAca66776040003
    TAYLOR, David Hunter
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    BritishBank Executive70908350001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr William Ainscough
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    01 sept. 2016
    Kelburn Court
    Birchwood
    WA3 6UT Warrington
    Exchange House
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NORTHERN VENTURE CAPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 juil. 2012
    Livré le 21 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 déc. 2003
    Livré le 17 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 23 juil. 2002
    Livré le 06 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Charge over assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Astley Homes Limited
    Transactions
    • 06 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 09 janv. 2002
    Livré le 19 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land at britannia road, sale, cheshire part of t/nos GM69556 and GM69557.
    Personnes ayant droit
    • Mr Roderick Clive Bond
    Transactions
    • 19 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land off mayfield drive lowton wigan lancs. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 30 août 1996
    Livré le 11 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property adjacent to 22 wigan road shevington wigan. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 1995
    Livré le 14 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the north of dunmail close, astley wigan greater manchester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1994
    Livré le 26 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at southport road lydiate t/no. MS175334. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1994
    Livré le 26 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    St denys childrens home pimlico road clitheroe t/no.LA739380. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Works deposit deed.
    Créé le 16 août 1994
    Livré le 02 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to british telecommunications PLC supplemental to the terms of a transfer, and deed of grant ,both of even date and/or this deed.
    Brèves mentions
    The amount from time to time standing to the credit of an interest earning deposit account opened in the joint names of lawrence graham of 190 strand, london, WC2R 1JN and addleshaw sons & latham of dennis house, marsden street, manchester , at the royal bank of scotland PLC, ( child & co branch) 1 fleet street, london. EC4Y 1BD.
    Personnes ayant droit
    • British Telecommunciations PLC,
    Transactions
    • 02 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 août 1994
    Livré le 17 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at preston road grimsargh preston t/no.LA386184. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mai 1994
    Livré le 14 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a joint venture agreement dated 25 may 1994
    Brèves mentions
    Park mount farm congleton road macclesfield cheshire t/no.CH281002.
    Personnes ayant droit
    • Casilton Homes Limited
    Transactions
    • 14 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1993
    Livré le 06 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land to be known as plots 1 and 2 the spinney preston road standish t/no.GM571449. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 janv. 1993
    Livré le 12 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a joint venture agreement
    Brèves mentions
    Land at phoenix hotel phoenix street sandycroft deeside clwyd.
    Personnes ayant droit
    • Silkavon Limited
    Transactions
    • 12 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the south side of brandreth delph parbold together with all fixtures and fittitngs.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings to the north side of sandes avenue kendal together with all fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 28 sandes avenue kendal together with all fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 10 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the south side of the sedgwick to kendal road sedgwick together with all fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 10 juil. 1992
    Livré le 14 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital and all patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 20 nov. 1991
    Livré le 05 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000
    Brèves mentions
    Fh land nos. 123 to 135 (odd) cleveleys avenue, cleveleys, wyre, lancaster t/NOLA503822.
    Personnes ayant droit
    • Cb Realisations Limited
    Transactions
    • 05 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 1989
    Livré le 02 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land in sandes avenue, kendal.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juin 1988
    Livré le 03 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and hereditaments situate and k/a hammarbank rayrigg road windermere cumbria.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 25 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 21 avr. 1987
    Livré le 23 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and premises known as fountain house (formerly known as winchester house) fountain street, manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 20 janv. 1987
    Livré le 21 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from william ainscough developments limited to chargee
    Brèves mentions
    F/H- 1) land in stoney lane parbold lancashire 2) land at brandreth house brandreth delph, parbold lancashire 3) land at brandreth park lancaster lane, parbold lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1986
    Livré le 14 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at high street and cross street, standish near wigan, greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1986Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0