RUSCH MANUFACTURING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUSCH MANUFACTURING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00551840
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUSCH MANUFACTURING LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe RUSCH MANUFACTURING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O TELEFLEX MEDICAL
    Stirling Road
    Cressex Business Park
    HP12 3ST High Wycombe
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUSCH MANUFACTURING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VUOTO LIMITED09 nov. 200509 nov. 2005
    RUSCH MANUFACTURING (UK) LIMITED20 déc. 199020 déc. 1990
    WARNE SURGICAL PRODUCTS LIMITED 09 juil. 195509 juil. 1955

    Quels sont les derniers comptes de RUSCH MANUFACTURING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 déc. 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour RUSCH MANUFACTURING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    1 pagesSH20

    Divers

    Memorandum of capital - processed 15/09/09
    1 pagesMISC

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Certificat de changement de nom

    Company name changed vuoto LIMITED\certificate issued on 15/06/09
    2 pagesCERTNM

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    7 pages363s

    Statuts

    12 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed rusch manufacturing (uk) LIMITED\certificate issued on 09/11/05
    2 pagesCERTNM

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes établis au 26 déc. 2004

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de RUSCH MANUFACTURING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Secrétaire
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    IrishCompany Secretary127397580001
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Administrateur
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishChartered Accountant127397580001
    WISEMAN, Gordon Alexander
    31 Llewellyn Avenue
    BT27 4AG Lisburn
    County Antrim
    Administrateur
    31 Llewellyn Avenue
    BT27 4AG Lisburn
    County Antrim
    BritishManager38330980001
    ROYSTON (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    Royston House 34 Upper Queen Street
    BT1 6HG Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Secrétaire
    Royston House 34 Upper Queen Street
    BT1 6HG Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    16335320001
    CHANCE, Steven K
    1212 Weybridge Lane
    Radnor
    Pennsylvania 19087-4635
    Usa
    Administrateur
    1212 Weybridge Lane
    Radnor
    Pennsylvania 19087-4635
    Usa
    AmericanCo Director64553770001
    ELLERKAMP, William Gerrard
    28 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Administrateur
    28 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    UsManaging Director30659080001
    HATCH, Lewis Emery
    2000 Red Maple Grove
    Ambler
    FOREIGN Pennsylvania 19002
    Usa
    Administrateur
    2000 Red Maple Grove
    Ambler
    FOREIGN Pennsylvania 19002
    Usa
    AmericanCo Director24647070001
    HEWITT, James Archer
    2 Wood Lane End
    Lurgan
    BT66 7HB Craigavon
    County Armagh
    Administrateur
    2 Wood Lane End
    Lurgan
    BT66 7HB Craigavon
    County Armagh
    BritishPlant Manager41055270001
    JOHNSON, Berneard James Mary
    19 Priests Lane
    Bloars Road
    BT27 5RB Lisburn
    County Antrim
    Administrateur
    19 Priests Lane
    Bloars Road
    BT27 5RB Lisburn
    County Antrim
    BritishCo Director80681320002
    MCCONVILLE, Trevor
    36 Elm Hurst
    Magheralin
    BT67 0QH Craigavon
    County Armagh
    Administrateur
    36 Elm Hurst
    Magheralin
    BT67 0QH Craigavon
    County Armagh
    BritishCo Director24647060001
    PERRY, Colin Edward
    23 Bridgeways
    BT32 4ED Banbridge
    County Down
    Administrateur
    23 Bridgeways
    BT32 4ED Banbridge
    County Down
    BritishCo Director24647050001
    PURSELL, Ian Graham
    The Grange Ware Farm
    East Hill
    EX11 1PJ Ottery St Mary
    Devon
    Administrateur
    The Grange Ware Farm
    East Hill
    EX11 1PJ Ottery St Mary
    Devon
    BritishManufacturing Director45029840001
    SILCOCK, Paula Joyce
    26 Cottage Hill
    BT67 9NJ Dollingstown
    County Armagh
    North Ireland
    Administrateur
    26 Cottage Hill
    BT67 9NJ Dollingstown
    County Armagh
    North Ireland
    BritishManager107475270001

    RUSCH MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 13 sept. 1989
    Livré le 20 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lands of the borough of lurgan having 5.69 acres approx & land in the town of lurgan county armagh with 2.3630 acres approx (for further details refer to doc 395 ref M212C).
    Personnes ayant droit
    • The Investment Bank of Ireland Limited
    Transactions
    • 20 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 17 mars 1986
    Livré le 26 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on (see doc M94). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 26 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Over all book debts charge
    Créé le 17 mars 1986
    Livré le 26 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts & other debts now & from to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 26 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 20 mai 1985
    Livré le 30 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee agreement dated 20/5/85.
    Brèves mentions
    (See doc M88). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Department of Economic Development
    Transactions
    • 30 mai 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 12 oct. 1984
    Livré le 17 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 1000000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    (See M87). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Department of Economic Development
    Transactions
    • 17 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 31 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1984
    Livré le 18 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that piece of land situate at and over hampshire and having an area of 0.5443 acres (approx) being plot 40B walworth industrial estate.
    Personnes ayant droit
    • London & Arab Investments Limited
    Transactions
    • 18 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 06 déc. 1983
    Livré le 10 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 216000
    Brèves mentions
    All that piece of land situate at and over hampshire and having an area of 0.5443 acres (approx) being plot 40B walworth industrial estate.
    Personnes ayant droit
    • London & Arab Investments Limited
    Transactions
    • 10 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    Supplemental debenture
    Créé le 23 mars 1982
    Livré le 31 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the debenture dated 26.9.80
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery stock-in-trade, work-in-progress etc (see doc. M84).
    Personnes ayant droit
    • Northern Ireland Deelopment Agency
    Transactions
    • 31 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 26 sept. 1980
    Livré le 07 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M83). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Investment Bank of Ireland Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 26 sept. 1980
    Livré le 03 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Stock-in-trade, work-in-progress. (See doc. M82).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Northern Ireland Development Agency
    Transactions
    • 03 oct. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0