00554636 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société00554636 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00554636
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 00554636 LIMITED ?

    • (3210) /

    Où se situe 00554636 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ernst & Young Llp
    PO BOX 61
    LS1 2JN Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 00554636 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRESSAC INTERCONNECT LIMITED02 oct. 199702 oct. 1997
    PRESSAC LIMITED15 sept. 195515 sept. 1955

    Quels sont les derniers comptes de 00554636 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2003

    Quels sont les derniers dépôts pour 00554636 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Divers

    Form 3.2 - statement of affairs
    9 pagesMISC

    Rapport du séquestre administratif

    15 pages3.10

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages405(1)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    19 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    0 pages363(288)

    legacy

    0 pages363(353)

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2002

    19 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    0 pages363(288)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2001

    20 pagesAA

    Statuts

    11 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    5 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de 00554636 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DARRINGTON, Paul Hiram
    14 Portland Crescent
    Stapleford
    NG9 7GT Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    14 Portland Crescent
    Stapleford
    NG9 7GT Nottingham
    Nottinghamshire
    British103684450001
    ASTILL, John Thomas
    10 Appian Close
    Borrowash
    DE72 3LY Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    10 Appian Close
    Borrowash
    DE72 3LY Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish58693960001
    CLAY, Phillip
    32 Quarry Road
    NG15 9AP Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    32 Quarry Road
    NG15 9AP Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish103878240001
    RIPPIN, David John
    66 Lock Lane
    Long Eaton
    NG10 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    66 Lock Lane
    Long Eaton
    NG10 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    British29781200001
    WARWICK, John Andrew
    43 St Therese Circle
    Hanceville
    Alabama
    35077
    United States
    Administrateur
    43 St Therese Circle
    Hanceville
    Alabama
    35077
    United States
    American90441930001
    WHITTAKER, David
    30 Orchard Close
    Boulton Moor
    DE24 5AE Derby
    Administrateur
    30 Orchard Close
    Boulton Moor
    DE24 5AE Derby
    British82130600002
    BARKER, Anthony
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    Secrétaire
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    British83350930001
    DAVID, Alastair Cameron
    Northumberland Road
    CV32 6HG Leamington Spa
    108
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Northumberland Road
    CV32 6HG Leamington Spa
    108
    Warwickshire
    United Kingdom
    British130261580001
    IDDON, Nicholas Peter
    24 The Willows
    Pleasley
    NG19 7SN Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    24 The Willows
    Pleasley
    NG19 7SN Mansfield
    Nottinghamshire
    British85524130001
    LANGWORTHY, David Anthony
    173 Cole Lane
    Borrowash
    DE72 3GP Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    173 Cole Lane
    Borrowash
    DE72 3GP Derby
    Derbyshire
    British3176320001
    PROSSER, Michael Trevelyan
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    British69196950002
    BARKER, Anthony
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    Administrateur
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    British83350930001
    GORDON, Harry Stuart
    Greylands Mereside Road
    Mere
    WA16 6QQ Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Greylands Mereside Road
    Mere
    WA16 6QQ Knutsford
    Cheshire
    British25073230002
    IDDON, Nicholas Peter
    24 The Willows
    Pleasley
    NG19 7SN Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    24 The Willows
    Pleasley
    NG19 7SN Mansfield
    Nottinghamshire
    British85524130001
    JEPSON, Michael John
    4a The Grove
    DE72 3AE Breaston
    Derbyshire
    Administrateur
    4a The Grove
    DE72 3AE Breaston
    Derbyshire
    British46915290001
    KILMURRY, Martin
    5557 Parkview Circle
    Birmingham
    Alabama 35242
    Usa
    Administrateur
    5557 Parkview Circle
    Birmingham
    Alabama 35242
    Usa
    British70733870002
    KING, Anthony Clive Garner
    Gowan Bank
    47 Broadway
    DE56 4BU Duffield
    Derbyshire
    Administrateur
    Gowan Bank
    47 Broadway
    DE56 4BU Duffield
    Derbyshire
    EnglandBritish108853950001
    LANGWORTHY, David Anthony
    173 Cole Lane
    Borrowash
    DE72 3GP Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    173 Cole Lane
    Borrowash
    DE72 3GP Derby
    Derbyshire
    British3176320001
    LEWIS, Huw Roderic
    26 Chattaway Drive
    Balsall Common
    CV7 7QH Coventry
    Warwickshire
    Administrateur
    26 Chattaway Drive
    Balsall Common
    CV7 7QH Coventry
    Warwickshire
    British13419660001
    MILLINGTON, Terence John
    319 Leake Road
    Gotham
    NG11 0LE Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    319 Leake Road
    Gotham
    NG11 0LE Nottingham
    Nottinghamshire
    British3315380001
    MUIR, Iain Brodie
    36 Muir Road
    EH48 2QH Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    36 Muir Road
    EH48 2QH Bathgate
    West Lothian
    British61285110001
    PROSSER, Michael Trevelyan
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    British69196950002
    ROPER, Colin
    3 Lancaster Avenue
    Stapleford
    NG9 7HH Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    3 Lancaster Avenue
    Stapleford
    NG9 7HH Nottingham
    Nottinghamshire
    British3315400001
    SNAITH, Colin
    Springfield Lodge
    1 Raneleigh Road
    WR14 1BQ Malvern Link
    Worcestershire
    Administrateur
    Springfield Lodge
    1 Raneleigh Road
    WR14 1BQ Malvern Link
    Worcestershire
    British86828990001
    STIBBARDS, Kevin Brian
    6 Langar Lane
    Harby
    LE14 4BL Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    6 Langar Lane
    Harby
    LE14 4BL Melton Mowbray
    Leicestershire
    British74827280001
    VAISEY, Alfred John
    8 Jacques Close
    Water Orton
    BA6 1TJ Warwickshire
    Administrateur
    8 Jacques Close
    Water Orton
    BA6 1TJ Warwickshire
    British30421960001
    WHITE, Geoffrey Charles
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    Administrateur
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    British86433340001
    WHITTAKER, David
    106 Gray Run
    Huntsville
    Alabama 35824
    Usa
    Administrateur
    106 Gray Run
    Huntsville
    Alabama 35824
    Usa
    British82130600001

    00554636 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 08 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Finance Parties
    Transactions
    • 08 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2005Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 24 mai 2006Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 02 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pressac Holdings Inc. as Chargee and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 02 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 23 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new presco 60 ton press serial no :- 5441.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 23 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 15 déc. 1994
    Livré le 15 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new ultrasonic film coating machine, serial no. 15942908.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 15 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 12 avr. 1994
    Livré le 12 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new kaco plant solder cell ii, serial no: 6ES5710/8M41 one new demag ET25-80 compact injection moulding machine, serial no: 7111-0039.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 12 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    00554636 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 juin 2002Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    G Wilson
    practitioner
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    practitioner
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0