CLYDE PUMPS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CLYDE PUMPS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00558720 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CLYDE PUMPS LIMITED ?
Adresse du siège social | Green Road Penistone S36 6BJ Sheffield |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CLYDE PUMPS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2016 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2017 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CLYDE PUMPS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 mai 2018 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 10 juin 2018 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 mai 2017 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour CLYDE PUMPS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauration par ordonnance du tribunal | 2 pages | AC92 | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jeremy Wade Smeltser le 26 sept. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Paul Andrew Cahill en tant qu'administrateur le 26 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Balkar Sohal en tant que directeur le 26 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Lucius Lilly en tant que directeur le 03 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Stephen Tsoris en tant qu'administrateur le 03 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Balkar Sohal le 22 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Edward Shanahan le 22 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Brown en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jeremy Wade Smeltser le 01 janv. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Lucius Lilly le 01 janv. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CLYDE PUMPS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHILL, Paul Andrew | Administrateur | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spx International Limited Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 202085370001 | ||||
SHANAHAN, Mark Edward | Administrateur | Ocean House, Towers Business Park Didsbury M20 2LY Manchester C/O Spx Europe Shared Services Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 165707440001 | ||||
SMELTSER, Jeremy Wade | Administrateur | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | United States | American | Cfo, Spx Flow, Inc. | 163313000001 | ||||
TSORIS, Stephen | Administrateur | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | United States | American | Director | 197069810001 | ||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Secrétaire | 22 Carrbrook Drive Atherton M46 9HT Manchester Lancashire | British | 1876370001 | ||||||
ASHMAN, Linda Margaret | Secrétaire | Blue Fields 421 Huddersfield Road, Shelley HD8 8NE Woodhouse Huddersfield West Yorkshire | British | 86730910001 | ||||||
BROWN, Thomas James | Secrétaire | 57 Randolph Road G11 7JJ Glasgow | British | Company Secretary | 60773560001 | |||||
TULLEY, Karen Ann | Secrétaire | Knottside Farm The Knott, Pateley Bridge HG3 5DQ Harrogate North Yorkshire | British | Solicitor | 59112980002 | |||||
ADAMS, Simon John | Administrateur | Bridgefoot Cottage Bridgefoot Silkstone S75 4LZ Barnsley South Yorkshire | British | Director | 68065980001 | |||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Administrateur | Apartment 301 Valley Mill Cottonfields Eagley Brook BL7 9DY Bolton Lancashire | England | British | Financial Director | 1876370002 | ||||
BAILEY, Roger | Administrateur | 51 Upper Hall View Northowram HX3 7ET Halifax West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 29110660002 | ||||
BOYD, Norman | Administrateur | 15 Marina Towers Boscombe BH5 1BJ Bournemouth Dorset | British | Director | 55402440001 | |||||
BROWN, Christopher John | Administrateur | The Grange Bent Lane Sutton In Craven BD20 7AL Keighley West Yorkshire | England | British | Company Director | 1698880001 | ||||
COOK, Christopher David | Administrateur | Beauchamp House Church Road CV35 8AN Sherbourne Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 1698890001 | ||||
DOWIE, Allan Cameron | Administrateur | Arkaig Place Newton Mearns G77 5PH Glasgow 7 | United Kingdom | British | Finance Director | 132053460001 | ||||
ELSBORG, Anton Cecil | Administrateur | Woodstock Thorpe Lane LS20 8LE Leeds West Yorkshire | England | British | Director | 93041580001 | ||||
EVANS, Simon James Peter | Administrateur | 2 Nursery Close Leyland PR5 1NS Preston Lancashire | British | Director | 45872320001 | |||||
HOLLAND, Mark Harry | Administrateur | 219 Huddersfield Road Thongsbridge HD9 3TT Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98168130001 | ||||
LILLY, Kevin Lucius | Administrateur | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | Usa | American | Director | 165775730001 | ||||
LINDA JEAN, Norman | Administrateur | 76 Ennerdale Drive CW12 4FL Congleton Cheshire | British | Customer Services Director | 71657260001 | |||||
MAKIN, David | Administrateur | 54 Lamb Hall Road Longwood HD7 7NW Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 45872440001 | |||||
MCBRIDE, Michael | Administrateur | 51a Middleton Lane Middleton St George DL2 1AL Darlington County Durham | British | Director | 45872470001 | |||||
MCCANN, Michael | Administrateur | Alderley 157 Longedge Lane Wingerworth S42 6PR Chesterfield Derbyshire | British | Director | 57468200001 | |||||
O'LEARY, Patrick Joseph | Administrateur | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13515 Nc 28277 Usa | United States | American | Business Director | 61807850002 | ||||
PENNING, Graham Michael | Administrateur | 36 Riley Park Kirkburton HD8 0SA Huddersfield West Yorkshire | England | British | Vice President Of Engineering | 12354670001 | ||||
PILKINGTON, Craig Edward | Administrateur | 233 Huddersfield Road Thongsbridge HD7 2TT Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 48655240001 | |||||
PRIDEAUX, Christopher Clive | Administrateur | 21a Primrose Lane Kirkburton HD8 0QY Huddersfield West Yorkshire | England | British | Managing Director | 64753680001 | ||||
SCOTT, Greaeme | Administrateur | 19 Rufford Road HD3 4RR Huddersfield West Yorkshire | British | Financial Director | 71161000001 | |||||
SOHAL, Balkar | Administrateur | Hambridge Road RG14 5TR Newbury C/O Spx Flow Technology Limited Berkshire United Kingdom | England | English | Chartered Accountant | 161546310001 | ||||
WHITTLE, Andrew Paul | Administrateur | 61 Doeford Close Culcheth WA3 4DL Warrington Cheshire | England | British | Director | 108088160001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLYDE PUMPS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clyde Union Db Limited | 06 avr. 2016 | S36 6BJ Penistone Green Road Sheffield United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CLYDE PUMPS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Créé le 24 sept. 1992 Livré le 07 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See form 395 refg m*91. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 24 janv. 1990 Livré le 05 févr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (as agent) and to the lenders (as defined) under each of the financing documents to which such obligor is a party | |
Brèves mentions (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 24 janv. 1990 Livré le 06 févr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from each obligor (as defined) to bankers trust company(the senior) leaders agent) as agent and trustee for itself, canadian imperial bank of commerce and bankers trust international limited (the senior leaders) under each of the financing. Ducuments to which such obligor is a party | |
Brèves mentions (Please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 27 juin 1989 Livré le 04 juil. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 27 juin 1989 Livré le 30 juin 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mai 1989 Livré le 15 mai 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0