OIS TEESSIDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOIS TEESSIDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00568950
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OIS TEESSIDE LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe OIS TEESSIDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OIS TEESSIDE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OIS TEESIDE LIMITED10 mars 199810 mars 1998
    THE DAMBUSTERS BUSINESS PARK LIMITED05 oct. 199205 oct. 1992
    YATES (LEICESTRELLA) LIMITED05 juil. 198205 juil. 1982
    YATES (LEICESTRELLA) LIMITED13 juil. 195613 juil. 1956

    Quels sont les derniers comptes de OIS TEESSIDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour OIS TEESSIDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 mars 2011

    4 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 45 Bowesfield Lane Stockton-on-Tees TS18 3YH England le 28 sept. 2010

    2 pagesAD01

    État du capital après une attribution d'actions au 19 août 2010

    • Capital: GBP 430,000
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolutions

    Re liquidator and dec of solvency 19/08/2010
    RES13

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Abigail Silk le 09 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    1 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    1 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OIS TEESSIDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SILK, Abigail
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Secrétaire
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    British131841500001
    MORRISON, Neil Steven
    PO BOX 115215
    Dubai
    Uae
    Administrateur
    PO BOX 115215
    Dubai
    Uae
    United Arab EmiratesBritish103664250003
    WESTWOOD, Alexander
    PO BOX 115215
    FOREIGN Dubai
    Uae
    Administrateur
    PO BOX 115215
    FOREIGN Dubai
    Uae
    United Arab EmiratesBritish67088470010
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    Secrétaire
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Scotland
    Secrétaire
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Scotland
    38777080002
    HARIMAU MANAGEMENT LIMITED
    61 Doughty Street
    WC1N 2NH London
    Secrétaire
    61 Doughty Street
    WC1N 2NH London
    58138690001
    ALLAN, Derek Macdonald
    37 Bernham Avenue
    AB39 2WD Stonehaven
    Administrateur
    37 Bernham Avenue
    AB39 2WD Stonehaven
    British63077290001
    COWPERTHWAITE, Graham
    Greenleas Old Inn Road
    Findon Portlethen
    AB1 4RN Aberdeen
    Administrateur
    Greenleas Old Inn Road
    Findon Portlethen
    AB1 4RN Aberdeen
    British44329870001
    GOODWIN, Adrian Jonathan
    1 Culter Den
    Peterculter
    AB1 0WA Aberdeen
    Administrateur
    1 Culter Den
    Peterculter
    AB1 0WA Aberdeen
    United KingdomBritish32383580002
    LOCKE, Alasdair James Dougall
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    Administrateur
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    United KingdomBritish115457770001
    MCNULTY, Anthony
    10 Lowther Close
    TS22 5NX Billingham
    Cleveland
    Administrateur
    10 Lowther Close
    TS22 5NX Billingham
    Cleveland
    EnglandBritish33337440002
    MILNE, Peter John
    Craigwood
    Blairs
    AB12 5YT Aberdeen
    Administrateur
    Craigwood
    Blairs
    AB12 5YT Aberdeen
    ScotlandBritish33613400008
    ROUND, Robert Michael
    Hill Cottage Shop Hill
    Mareham Le Fen
    PE22 7QP Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    Hill Cottage Shop Hill
    Mareham Le Fen
    PE22 7QP Boston
    Lincolnshire
    British26937100001
    SLATER, Brian Richard
    18 Malvern Close
    NG34 7RA Sleaford
    Lincolnshire
    Administrateur
    18 Malvern Close
    NG34 7RA Sleaford
    Lincolnshire
    British26937110001
    TILLY, David Gordon
    Two Cottages
    Kirkby On Bain
    LN10 6YT Woodhall Spa
    Lincoln
    Administrateur
    Two Cottages
    Kirkby On Bain
    LN10 6YT Woodhall Spa
    Lincoln
    British47267070001
    HARIMAU MANAGEMENT LIMITED
    61 Doughty Street
    WC1N 2NH London
    Administrateur
    61 Doughty Street
    WC1N 2NH London
    58138690001
    UNIGROUP PLC
    61 Doughty Street
    WC1N 2NH London
    Administrateur
    61 Doughty Street
    WC1N 2NH London
    37798720001

    OIS TEESSIDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 oct. 2001
    Livré le 10 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the finance parties (as defined) under all or any of the financing documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity Assecurity Trustee for Itself and on Behalf of Each Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 10 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 nov. 1987
    Livré le 30 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at tattershall thorpe lincoln & the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 29 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 août 1981
    Livré le 04 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital and all fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery and heritable property in scotland (please see doc M72).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 29 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OIS TEESSIDE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 juin 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Bernard Stephen
    Bdo Llp, 4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    practitioner
    Bdo Llp, 4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0