RUBIX U.K. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUBIX U.K. LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00569290
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUBIX U.K. LIMITED ?

    • Commerce de gros d'autres machines et équipements (46690) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe RUBIX U.K. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Dakota House
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUBIX U.K. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRAMMER UK LIMITED03 janv. 200703 janv. 2007
    BSL BRAMMER LIMITED31 janv. 200531 janv. 2005
    BSL LIMITED25 janv. 199025 janv. 1990
    BEARING SERVICE LIMITED23 juil. 195623 juil. 1956

    Quels sont les derniers comptes de RUBIX U.K. LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RUBIX U.K. LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour RUBIX U.K. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    53 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    52 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Helen Sarah Shaw en tant que directeur le 31 mars 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    52 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Rubix International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 déc. 2021

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Richard Bowring en tant qu'administrateur le 20 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    52 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed brammer uk LIMITED\certificate issued on 01/09/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 sept. 2022

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Cecile Parker en tant qu'administrateur

    5 pagesRP04TM01

    Cessation de la nomination de Cécile Parker en tant que directeur le 02 févr. 2022

    2 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    28 mars 2022Clarification A second filed TM01 was registered on 28/03/2022.

    Cessation de la nomination de Mark Robert Graham Dixon en tant que directeur le 21 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Vincent Michael Benedict Mcgurk en tant qu'administrateur le 18 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 005692900007, créée le 14 janv. 2022

    21 pagesMR01

    Nomination de Ms Helen Sarah Shaw en tant qu'administrateur le 17 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    48 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    33 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Rubix International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 déc. 2019

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Claverton Court Claverton Road Wythenshawe Manchester M23 9NE à Dakota House Concord Business Park Manchester M22 0RR le 16 déc. 2019

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de RUBIX U.K. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOWRING, Richard
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    Administrateur
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    United KingdomBritish265039130001
    MCGURK, Vincent Michael Benedict
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    Administrateur
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    EnglandBritish197598780001
    BUTLER, John William
    Little Garth
    Tirley Lane
    CW6 0JZ Utkinton
    Cheshire
    Secrétaire
    Little Garth
    Tirley Lane
    CW6 0JZ Utkinton
    Cheshire
    British89090380002
    KAVANAGH, Michael John
    28 Pasture Field Road
    Peel Hall
    M22 5JU Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    28 Pasture Field Road
    Peel Hall
    M22 5JU Manchester
    Lancashire
    British7442440001
    SCARRATT, Andrew Nigel
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Secrétaire
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    British11376090002
    SHELTON, David
    63 Higher Lane
    WA13 0BZ Lymm
    Cheshire
    Secrétaire
    63 Higher Lane
    WA13 0BZ Lymm
    Cheshire
    British69563120005
    SOUTHERN, David
    Holly Trees
    Church Farm Podington
    NN29 THS Wellingborough
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Holly Trees
    Church Farm Podington
    NN29 THS Wellingborough
    Northamptonshire
    British162259710001
    ASHMORE, Stephen, Mr.
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    EnglandBritish232880380001
    BUTLER, John William
    Little Garth
    Tirley Lane
    CW6 0JZ Utkinton
    Cheshire
    Administrateur
    Little Garth
    Tirley Lane
    CW6 0JZ Utkinton
    Cheshire
    EnglandBritish89090380002
    COOPER, Anthony Bernard
    9 Packsaddle Park
    Prestbury
    SK10 4PU Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    9 Packsaddle Park
    Prestbury
    SK10 4PU Macclesfield
    Cheshire
    British7442490003
    DAVIS, Robert William
    6 Bankfield Drive
    Holmbridge
    HD9 2PH Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Bankfield Drive
    Holmbridge
    HD9 2PH Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish87301370001
    DIXON, Mark Robert Graham
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    Administrateur
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    EnglandBritish51467220005
    FFOULKES-JONES, Robert Garson
    The Cliff Cliff Road
    Acton Bridge
    CW8 3QP Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Cliff Cliff Road
    Acton Bridge
    CW8 3QP Northwich
    Cheshire
    British12535400001
    FRASER, Ian Robert
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    EnglandBritish28474370002
    GRENNAN, Michael Anthony
    61 Ganton Road
    WS3 3XQ Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    61 Ganton Road
    WS3 3XQ Walsall
    West Midlands
    British26531410001
    HODKINSON, Steven Paul
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    EnglandBritish207071940001
    HOLLYWOOD, David John
    Stoney Way
    Bovingdon Green
    SL7 2JH Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Stoney Way
    Bovingdon Green
    SL7 2JH Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish114080730001
    HOLMES, Barrington Peter
    48 Meadow Drive
    Prestbury
    SK10 4EZ Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    48 Meadow Drive
    Prestbury
    SK10 4EZ Macclesfield
    Cheshire
    British11376100001
    HOLROYD, Gary
    Woodside
    9 The Barkery Newby
    TS8 0AW Middlesbrough
    Administrateur
    Woodside
    9 The Barkery Newby
    TS8 0AW Middlesbrough
    British93490550001
    JACKSON, Lawrence
    3 Turnberry Court
    NG12 4DL Edwalton
    Administrateur
    3 Turnberry Court
    NG12 4DL Edwalton
    British93072990001
    JENNINGS, Paul
    Miskin House
    Grange Close
    LN1 2UY Ingham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Miskin House
    Grange Close
    LN1 2UY Ingham
    Lincolnshire
    EnglandBritish75844470001
    JONES, Graham Rhys
    3 Greystokes
    Aughton
    L39 5HE Ormskirk
    Lancashire
    Administrateur
    3 Greystokes
    Aughton
    L39 5HE Ormskirk
    Lancashire
    EnglandBritish11743340002
    MAGRATH, Duncan Jonathan
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    United KingdomBritish167161300001
    MANNERING, Jeffrey
    6 The Beeches
    WA6 0QL Helsby
    Cheshire
    Administrateur
    6 The Beeches
    WA6 0QL Helsby
    Cheshire
    EnglandBritish127528160001
    MILLER, John Charles
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    Administrateur
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    United KingdomBritish81543110001
    MILLS, Roger Harold Simpson
    7 Madeley Close
    Hale
    WA14 3NJ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    7 Madeley Close
    Hale
    WA14 3NJ Altrincham
    Cheshire
    British2084770001
    PARK, Charlotte Katherine
    6 Hill Carr
    Saint Margarets Road
    WA14 2BE Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    6 Hill Carr
    Saint Margarets Road
    WA14 2BE Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish71869510001
    PARKER, Cécile
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    Administrateur
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    EnglandFrench255607530001
    RITCHIE, Ian Alexander
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    United KingdomBritish94851550006
    ROGERS, Neil John Heber
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    EnglandBritish217559740001
    SCARRATT, Andrew Nigel
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    United KingdomBritish11376090002
    SHAW, Helen Sarah
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    Administrateur
    Concord Business Park
    M22 0RR Manchester
    Dakota House
    England
    EnglandBritish189453380001
    SHELTON, David
    63 Higher Lane
    WA13 0BZ Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    63 Higher Lane
    WA13 0BZ Lymm
    Cheshire
    British69563120005
    SHENTON, Garth
    110 Broomhill Road
    BS4 4SA Bristol
    Avon
    Administrateur
    110 Broomhill Road
    BS4 4SA Bristol
    Avon
    British30095770001
    SHORT, Christopher David
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    Administrateur
    Claverton Court
    Claverton Road
    M23 9NE Wythenshawe
    Manchester
    United KingdomBritish102462770003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBIX U.K. LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    England
    06 avr. 2016
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03909967
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0