TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 00576922 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1st Floor River Court Mill Lane GU7 1EZ Godalming Surrey England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 août 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mai 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 mars 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 13 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 mars 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2024 | 11 pages | AA | ||
Cessation de Nigel Kenrick Grosvenor Prescot en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 avr. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Simon Nicholas Lough en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 avr. 2025 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de la nomination de Alanna Yvette Lee en tant que directeur le 30 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Nicola Jane Denoon Duncan en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Alexander Philip Clark en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2023 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2022 | 13 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Christopher Mark Wellby en tant que directeur le 31 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Philip James Lough en tant que directeur le 31 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Kathleen Child-Villiers en tant qu'administrateur le 03 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2021 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward John Leatham Richardson le 28 mars 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2020 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Eleanor Mary Fiona Sykes en tant que directeur le 28 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2019 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Tristam Norwood Dugdale en tant que directeur le 04 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2018 | 14 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREWER, Simon Robert | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | British | 165598940001 | |||||
| CHILD-VILLIERS, Kathleen | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | American | 188946890001 | |||||
| CLARK, Alexander Philip | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | British | 331179700001 | |||||
| DENOON DUNCAN, Nicola Jane | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | British | 331179950001 | |||||
| LOUGH, Simon Nicholas | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | English | 55650350002 | |||||
| PRESCOT, Nigel Kenrick Grosvenor | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | United Kingdom | British | 70918800001 | |||||
| RICHARDSON, Edward John Leatham | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | British | 186476830002 | |||||
| ALLEN, Pamela Faith | Secrétaire | Anderida Crowborough Road Nutley TN22 3HT Uckfield East Sussex | British | 13563380001 | ||||||
| ATWOOD, Robert Charles | Secrétaire | Breakstones Speldhurst Road Langton Green TN3 0JL Tunbridge Wells Kent | British | 14065630001 | ||||||
| BAKER, Andrew James | Secrétaire | Bethany 93 Lingfield Road TN8 5DY Edenbridge Kent | British | 39578480001 | ||||||
| DEVONSHIRE, Peter John George, Commander | Secrétaire | Little Foxes Argos Hill TN20 6NS Mayfield East Sussex | British | 38102470001 | ||||||
| HALLINGS POTT, Nicholas John | Secrétaire | Hackhurst Farm Lower Dicker BN27 4BP Hailsham East Sussex | British | 50978790002 | ||||||
| MUSGROVE, Paul Thomas | Secrétaire | The Cottage Upper Dicker BN27 3QJ Hailsham East Sussex | British | 71143370001 | ||||||
| NERTNEY, Joanne Elizabeth | Secrétaire | Toys Hill TN16 1QG Westerham Weardale Lodge Kent England | 196075520001 | |||||||
| ROSS-HURST, Rupert William Kenneth, Major | Secrétaire | Chapel Flat Temple Grove School Herons Ghyll TN22 4DA Uckfield Eastsussex | British | 35381790001 | ||||||
| ATWOOD, Robert Charles | Administrateur | Breakstones Speldhurst Road Langton Green TN3 0JL Tunbridge Wells Kent | England | British | 14065630001 | |||||
| BAWTREE, Ronald David | Administrateur | Hazelwood School Wolfs Hill Limpsfield RH8 0QU Oxted Surrey | British | 46621970001 | ||||||
| BREWER, Robert Christopher | Administrateur | Ballards Cottage Ballards Lane Limpsfield RH8 0SN Oxted Surrey | England | British | 15565290001 | |||||
| BROWN, Peter Robert | Administrateur | East Lodge Duddleswell TN22 3JL Uckfield East Sussex | British | 38675170002 | ||||||
| BUTLER, Alexandra Frances | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | British | 165901050001 | |||||
| COBB, John Martin | Administrateur | Pinehurst Eridge Road Eridge Green TN3 9JU Tunbridge Wells Kent | British | 58540050001 | ||||||
| CRIPPS, Christopher Anthony | Administrateur | The Paddocks Butlers Green RH16 4BJ Hayward Heath West Sussex | British | 2003320001 | ||||||
| DALTON, Julia Clare | Administrateur | c/o Alan Jones 10 Ickham Court Farm, The Street Ickham CT3 1QQ Canterbury Longstraw Barn Kent England | England | British | 73653640002 | |||||
| DARLING, Rory Nicholas Moriarty | Administrateur | Toys Hill TN16 1QG Westerham Weardale Lodge Kent England | England | British | 186477150001 | |||||
| DUGDALE, Mark Tristam Norwood | Administrateur | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | England | British | 85782480002 | |||||
| ELLIS, Simon Richard | Administrateur | c/o Alan Jones 10 Ickham Court Farm, The Street Ickham CT3 1QQ Canterbury Longstraw Barn Kent England | England | British | 51513630001 | |||||
| FABRE, Clarissa Dorothy Alice, Dr | Administrateur | Hippocrene Farm Buckham Hill TN22 5XZ Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | 122814630001 | |||||
| FERGUSON, John Charles Corry | Administrateur | Wood Cottage Pook Reed Lane TN21 0AU Heathfield East Sussex | United Kingdom | British | 41660570001 | |||||
| GEE, Cynthia Frances Heath | Administrateur | Anchorage Main Street Northiam TN31 6NB Rye East Sussex | British | 13563420001 | ||||||
| GILLESPIE FRANKLIN, Annette Kim | Administrateur | Ardingly College College Road, Ardingly RH17 6SQ Haywards Heath West Sussex | Australian | 65620260001 | ||||||
| HALL, Christopher Sandford | Administrateur | Great Danegate Eridge Green TN3 9HU Tunbridge Wells Kent | England | British | 13563430001 | |||||
| HALL, Colin James | Administrateur | Great Danegate Farm Cottage Eridge Green TN3 9HU Tunbridge Wells Kent | England | British | 142884360001 | |||||
| HANBURY, Benjamin John | Administrateur | Cogans Piltdown TN22 3XR Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | 20950400001 | |||||
| HENDLEY, Rosalind Emma | Administrateur | 83 Henwood Green Road Pembury TN2 4LP Tunbridge Wells Kent | British | 70970630001 | ||||||
| HOWELLS, Edward William | Administrateur | Bernards Close HP16 0BU Great Missenden Redcroft Buckinghamshire England | England | British | 152710480001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TEMPLE GROVE SCHOOLS TRUST LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Simon Nicholas Lough | 28 avr. 2025 | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | Non |
Nationalité: English Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Nigel Kenrick Grosvenor Prescot | 06 avr. 2016 | Mill Lane GU7 1EZ Godalming 1st Floor River Court Surrey England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0