J.ARMSTRONG TODD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ.ARMSTRONG TODD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00578134
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J.ARMSTRONG TODD LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe J.ARMSTRONG TODD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 21 Wansbeck Business Park
    Rotary Way
    NE63 8QW Ashington
    Northumberland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de J.ARMSTRONG TODD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour J.ARMSTRONG TODD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juin 2011

    État du capital au 21 juin 2011

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gareth Sean Mc Keown le 04 mai 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gareth Sean Mc Keown le 04 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Declan Gerard Canavan le 04 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Peter Burns le 04 mai 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 30 avr. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2004

    7 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de J.ARMSTRONG TODD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MC KEOWN, Gareth Sean
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    Secrétaire
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    IrishAccountant113780990001
    BURNS, John Peter
    Pine Lodge
    27 Portadown Road
    BT61 9EE Armagh
    County Armagh
    Administrateur
    Pine Lodge
    27 Portadown Road
    BT61 9EE Armagh
    County Armagh
    Northern IrelandBritishFlooring Contractor144357590001
    CANAVAN, Declan Gerard
    Ashtree House
    4c Old Road Poyntzpass
    BT35 6TQ Newry
    County Down
    Administrateur
    Ashtree House
    4c Old Road Poyntzpass
    BT35 6TQ Newry
    County Down
    United KingdomIrishQuantity Surveyor145386800001
    MC KEOWN, Gareth Sean
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    Administrateur
    11 Lake Road
    Cullyhanna
    BT35 0LR Newry
    Co Down
    United KingdomIrishAccountant113780990001
    BELL, Malcolm Peter
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    British98010750001
    MERRON, Imelda Anne
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    Secrétaire
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    IrishCompany Director82517680002
    PORTEOUS, Gavin
    Highcroft Elvaston Road
    NE46 2HH Hexham
    Northumberland
    Secrétaire
    Highcroft Elvaston Road
    NE46 2HH Hexham
    Northumberland
    British10800520002
    BELL, Malcolm Peter
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    26 Moor Lane
    NE20 9AD Darras Hall
    Newcastle Upon Tyne
    BritishBusiness Manager98010750001
    CLARKSON, Joseph
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishFlooring Contractor10800570001
    CLARKSON, Norah
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    26 Otterburn Avenue
    South Wellfield
    NE25 9QL Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishMarried Woman10800540001
    CLARKSON, Peter
    Teachers Cottage
    Ordley Village
    NE46 1SX Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Teachers Cottage
    Ordley Village
    NE46 1SX Hexham
    Northumberland
    BritishFlooring Contractor10800550001
    LOGAN, Robert Carr
    93 Beach Road
    Tynemouth
    NE30 2TR North Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    93 Beach Road
    Tynemouth
    NE30 2TR North Shields
    Tyne & Wear
    BritishBusiness Manager101154020001
    MERRON, Imelda Anne
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    Administrateur
    12 The Glen
    BT35 8BS Newry
    County Down
    IrishCompany Secretary82517680002

    J.ARMSTRONG TODD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £650,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 1995
    Livré le 10 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of malcolm peter bell
    Brèves mentions
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Malcolm Peter Bell
    Transactions
    • 10 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 1995
    Livré le 10 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of joseph clarkson
    Brèves mentions
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Joseph Clarkson
    Transactions
    • 10 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 1995
    Livré le 10 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of peter clarkson
    Brèves mentions
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Peter Clarkson
    Transactions
    • 10 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 1995
    Livré le 10 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee according to the credit balances from time to time on the current account of norah clarkson
    Brèves mentions
    Unit 1B north tyne industrial estate whitley road longbenton tyne and wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Norah Clarkson
    Transactions
    • 10 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1983
    Livré le 05 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold unit 1B north tyne industrial estate, whitley road, longbenton, tyne and wear. Title no. Ty 19873.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 12 janv. 1981
    Livré le 16 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,711.50 & further advances not exceeding £4,500 in aggregate
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Counil of the City of Newcastle upon Tyne
    Transactions
    • 16 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 23 mai 1979
    Livré le 29 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, goodwill & uncalled capital with all buildings, fixtures fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1978
    Livré le 01 sept. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate in or near stowell street, newcastle upon tyne, with buildings and premises erected thereon and known as nordon house.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1978Enregistrement d'une charge
    • 27 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0