THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 00579091 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?
| Adresse du siège social | Tandy House Regal Way WD24 4YE Watford England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 mars 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Edward Van Berckel en tant que directeur le 23 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 05 avr. 2023 au 30 sept. 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Niki Michael en tant que directeur le 24 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2021 | 33 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2020 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Charles Edward Van Berckel en tant qu'administrateur le 07 déc. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Kate Major en tant qu'administrateur le 26 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Danny Kindell en tant qu'administrateur le 26 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Frances Mary Ridgway en tant que directeur le 22 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Robert David Blanc en tant que directeur le 22 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicole Louise Coogan en tant que directeur le 22 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Madeleine Cassidy en tant qu'administrateur le 22 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Stephen Cooke en tant que directeur le 27 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSIDY, Madeleine Anne | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | Irish | 113240060002 | |||||
| COLLIER, Henry Alexander | Administrateur | 250 East End Road N2 8AU London The Bobath Centre England | England | British | 147312290001 | |||||
| KINDELL, Danny | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | British | 280948340001 | |||||
| MAJOR, Kate | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | British | 280949990001 | |||||
| TINKLEPAUGH, Ann | Administrateur | Highgate West Hill N6 6AS London 17 England | England | British | 180588680001 | |||||
| WALDER, Robert Anthony | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | British | 76543100001 | |||||
| DALTON, Kerry Caroline | Secrétaire | 18 Fairway IG8 7RB Woodford Green Essex | British | 84241000002 | ||||||
| DOWNTON, Margaret | Secrétaire | 85 Inderwick Road N8 9LA London | British | 78789420001 | ||||||
| MAYNE-CONSTANTINOU, Claire Esther | Secrétaire | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | 225928100001 | |||||||
| ONOCHIE, Edmund Chiedy | Secrétaire | 17 Surrey Court Broughton Avenue Barnet N3 3EP London | British | 52017340001 | ||||||
| PEARCE, Jayne Anne Louise, M/S | Secrétaire | 2 Millwind Court Dollis Road NW7 1LA London | British | 30793860003 | ||||||
| SHANKS, Ann Catherine | Secrétaire | 2a Oak Lodge Avenue IG7 5HZ Chigwell Essex | British | 55711180001 | ||||||
| SHEFFIELD, Simon Arthur | Secrétaire | 68 Parade Mansions NW4 3AU London | British | 3373600001 | ||||||
| STALBOW, Michael Robert | Secrétaire | Bradbury House 250 East End Road N2 8AU London | 191705110001 | |||||||
| BLANC, Timothy Robert | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | British | 157277600001 | |||||
| BONHAMCARTER, Raymond | Administrateur | 7 Westheath Avenue NW11 7QS London | British | 3373610001 | ||||||
| BROMLEY, Ida | Administrateur | 6 Belsize Grove NW3 4UN London | England | British | 44527790001 | |||||
| CASH, Loretta | Administrateur | 3 Valencia Road HA7 4JL Stanmore Middlesex | British | 7284670001 | ||||||
| COOGAN, Nicole Louise | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | British | 260759220001 | |||||
| COOKE, Peter Stephen | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House Hertfordshire England | Wales | British | 191655250002 | |||||
| DICKINSON, Liesl | Administrateur | 23 Woodland Road Maple Cross WD3 2ST Rickmansworth Hertfordshire | English | 28669300001 | ||||||
| FARMER, Simon, Dr | Administrateur | 8 Saint Pauls Place N1 2QE London | British | 69957640001 | ||||||
| FLAX, Peter Howard | Administrateur | 70450 Placerville Thunderbirds Heights CA 92270 Ranch Miraoe Usa | British | 57664920002 | ||||||
| JOHNSON, Helena, Dr | Administrateur | Tilery Wood Wynyard Village TS22 5QR Billingham 1 Stockton On Tees Uk | England | British | 184474030001 | |||||
| LATNER, Stephen | Administrateur | 15 Stormont Road N6 4NS London | England | British | 30112460001 | |||||
| MACEACHARN, Neil, Captain | Administrateur | Quiberon Limes Lane PL14 4HP Liskeard Cornwall | British | 40824890002 | ||||||
| MAXWELL, John, Doctor | Administrateur | 53 Viceroy Court Prince Albert Road NW8 7PS London | British | 3373640001 | ||||||
| MCCOY, Dympna Geraldine | Administrateur | Long Park HP6 5LA Amersham 34 England | England | British | 197747650001 | |||||
| MEEK, Judith, Dr | Administrateur | 4 Palace Road N8 8QJ London | United Kingdom | British | 105054460001 | |||||
| MICHAEL, Niki | Administrateur | 250 East End Road N2 8AU London The Bobath Centre England | England | British | 231770960001 | |||||
| MUSHIN, Anna, Dr | Administrateur | 57 Highfield Gardens NW11 9HA London | British | 71486820001 | ||||||
| NOTTAGE, Raymond Frederick Tritton | Administrateur | Flat 29 119 Haverstock Hill NW3 4RS London | British | 3373660002 | ||||||
| RIDGWAY, Frances Mary | Administrateur | Regal Way WD24 4YE Watford Tandy House England | England | British | 58170060002 | |||||
| SEGAL, Raymond Phillip | Administrateur | 29e Fitzjohns Avenue NW3 5JY London | British | 39783180001 | ||||||
| SHUBROOK, Anthony | Administrateur | 24 Broomsleigh Street NW6 1QH London | British | 24366340001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 25 janv. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0