THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 00579091
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Adresse du siège social
    Tandy House
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOBATH CENTRE06 févr. 198606 févr. 1986
    WESTERN CEREBRAL PALSEY CENTRE(THE)26 févr. 195726 févr. 1957

    Quels sont les derniers comptes de THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au09 mars 2024

    Quels sont les derniers dépôts pour THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Charles Edward Van Berckel en tant que directeur le 23 mars 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 05 avr. 2023 au 30 sept. 2023

    1 pagesAA01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Niki Michael en tant que directeur le 24 févr. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2021

    33 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2020

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Charles Edward Van Berckel en tant qu'administrateur le 07 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Kate Major en tant qu'administrateur le 26 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Danny Kindell en tant qu'administrateur le 26 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Frances Mary Ridgway en tant que directeur le 22 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Robert David Blanc en tant que directeur le 22 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicole Louise Coogan en tant que directeur le 22 juin 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Madeleine Cassidy en tant qu'administrateur le 22 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 09 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Peter Stephen Cooke en tant que directeur le 27 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASSIDY, Madeleine Anne
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandIrish113240060002
    COLLIER, Henry Alexander
    250 East End Road
    N2 8AU London
    The Bobath Centre
    England
    Administrateur
    250 East End Road
    N2 8AU London
    The Bobath Centre
    England
    EnglandBritish147312290001
    KINDELL, Danny
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandBritish280948340001
    MAJOR, Kate
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandBritish280949990001
    TINKLEPAUGH, Ann
    Highgate West Hill
    N6 6AS London
    17
    England
    Administrateur
    Highgate West Hill
    N6 6AS London
    17
    England
    EnglandBritish180588680001
    WALDER, Robert Anthony
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandBritish76543100001
    DALTON, Kerry Caroline
    18 Fairway
    IG8 7RB Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    18 Fairway
    IG8 7RB Woodford Green
    Essex
    British84241000002
    DOWNTON, Margaret
    85 Inderwick Road
    N8 9LA London
    Secrétaire
    85 Inderwick Road
    N8 9LA London
    British78789420001
    MAYNE-CONSTANTINOU, Claire Esther
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Secrétaire
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    225928100001
    ONOCHIE, Edmund Chiedy
    17 Surrey Court
    Broughton Avenue Barnet
    N3 3EP London
    Secrétaire
    17 Surrey Court
    Broughton Avenue Barnet
    N3 3EP London
    British52017340001
    PEARCE, Jayne Anne Louise, M/S
    2 Millwind Court
    Dollis Road
    NW7 1LA London
    Secrétaire
    2 Millwind Court
    Dollis Road
    NW7 1LA London
    British30793860003
    SHANKS, Ann Catherine
    2a Oak Lodge Avenue
    IG7 5HZ Chigwell
    Essex
    Secrétaire
    2a Oak Lodge Avenue
    IG7 5HZ Chigwell
    Essex
    British55711180001
    SHEFFIELD, Simon Arthur
    68 Parade Mansions
    NW4 3AU London
    Secrétaire
    68 Parade Mansions
    NW4 3AU London
    British3373600001
    STALBOW, Michael Robert
    Bradbury House
    250 East End Road
    N2 8AU London
    Secrétaire
    Bradbury House
    250 East End Road
    N2 8AU London
    191705110001
    BLANC, Timothy Robert
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandBritish157277600001
    BONHAMCARTER, Raymond
    7 Westheath Avenue
    NW11 7QS London
    Administrateur
    7 Westheath Avenue
    NW11 7QS London
    British3373610001
    BROMLEY, Ida
    6 Belsize Grove
    NW3 4UN London
    Administrateur
    6 Belsize Grove
    NW3 4UN London
    EnglandBritish44527790001
    CASH, Loretta
    3 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    3 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    British7284670001
    COOGAN, Nicole Louise
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandBritish260759220001
    COOKE, Peter Stephen
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    Hertfordshire
    England
    WalesBritish191655250002
    DICKINSON, Liesl
    23 Woodland Road
    Maple Cross
    WD3 2ST Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    23 Woodland Road
    Maple Cross
    WD3 2ST Rickmansworth
    Hertfordshire
    English28669300001
    FARMER, Simon, Dr
    8 Saint Pauls Place
    N1 2QE London
    Administrateur
    8 Saint Pauls Place
    N1 2QE London
    British69957640001
    FLAX, Peter Howard
    70450 Placerville
    Thunderbirds Heights
    CA 92270 Ranch Miraoe
    Usa
    Administrateur
    70450 Placerville
    Thunderbirds Heights
    CA 92270 Ranch Miraoe
    Usa
    British57664920002
    JOHNSON, Helena, Dr
    Tilery Wood
    Wynyard Village
    TS22 5QR Billingham
    1
    Stockton On Tees
    Uk
    Administrateur
    Tilery Wood
    Wynyard Village
    TS22 5QR Billingham
    1
    Stockton On Tees
    Uk
    EnglandBritish184474030001
    LATNER, Stephen
    15 Stormont Road
    N6 4NS London
    Administrateur
    15 Stormont Road
    N6 4NS London
    EnglandBritish30112460001
    MACEACHARN, Neil, Captain
    Quiberon Limes Lane
    PL14 4HP Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    Quiberon Limes Lane
    PL14 4HP Liskeard
    Cornwall
    British40824890002
    MAXWELL, John, Doctor
    53 Viceroy Court
    Prince Albert Road
    NW8 7PS London
    Administrateur
    53 Viceroy Court
    Prince Albert Road
    NW8 7PS London
    British3373640001
    MCCOY, Dympna Geraldine
    Long Park
    HP6 5LA Amersham
    34
    England
    Administrateur
    Long Park
    HP6 5LA Amersham
    34
    England
    EnglandBritish197747650001
    MEEK, Judith, Dr
    4 Palace Road
    N8 8QJ London
    Administrateur
    4 Palace Road
    N8 8QJ London
    United KingdomBritish105054460001
    MICHAEL, Niki
    250 East End Road
    N2 8AU London
    The Bobath Centre
    England
    Administrateur
    250 East End Road
    N2 8AU London
    The Bobath Centre
    England
    EnglandBritish231770960001
    MUSHIN, Anna, Dr
    57 Highfield Gardens
    NW11 9HA London
    Administrateur
    57 Highfield Gardens
    NW11 9HA London
    British71486820001
    NOTTAGE, Raymond Frederick Tritton
    Flat 29 119 Haverstock Hill
    NW3 4RS London
    Administrateur
    Flat 29 119 Haverstock Hill
    NW3 4RS London
    British3373660002
    RIDGWAY, Frances Mary
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    Administrateur
    Regal Way
    WD24 4YE Watford
    Tandy House
    England
    EnglandBritish58170060002
    SEGAL, Raymond Phillip
    29e Fitzjohns Avenue
    NW3 5JY London
    Administrateur
    29e Fitzjohns Avenue
    NW3 5JY London
    British39783180001
    SHUBROOK, Anthony
    24 Broomsleigh Street
    NW6 1QH London
    Administrateur
    24 Broomsleigh Street
    NW6 1QH London
    British24366340001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE BOBATH CENTRE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    25 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0