GALLPEN PRESS LIMITED(THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGALLPEN PRESS LIMITED(THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00581255
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?

    Adresse du siège social
    Starling Road
    Norwich
    NR3 3EL Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Russell Healey en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Notification de Michael Grapes en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Modification des coordonnées du secrétaire Russell David Healey le 05 avr. 2017

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Kevin Grapes le 05 avr. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell David Healey le 05 avr. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2016

    État du capital au 19 juil. 2016

    • Capital: GBP 471,428
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Russell David Healey le 19 juin 2016

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Russell David Healey le 19 juin 2016

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juil. 2015

    État du capital au 17 juil. 2015

    • Capital: GBP 471,428
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2014

    État du capital au 07 juil. 2014

    • Capital: GBP 471,428
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2010

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEALEY, Russell David
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    Secrétaire
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    BritishCompany Director37791180001
    GRAPES, Michael Kevin
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    Administrateur
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    United KingdomBritishTravel Agent13902740004
    HEALEY, Russell David
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    Administrateur
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    EnglandBritishAccountant37791180002
    CATCHPOLE, Linnie
    514 Hall Road
    NR4 6NQ Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    514 Hall Road
    NR4 6NQ Norwich
    Norfolk
    BritishAccountant35278370001
    METCALF, Andrew John
    115 Plantation Road
    Hellesdon
    NR6 5RH Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    115 Plantation Road
    Hellesdon
    NR6 5RH Norwich
    Norfolk
    British15538250001
    YOUNGS, Ian David
    Corner Barn
    Chapel Road East Ruston
    NR12 9AA Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Corner Barn
    Chapel Road East Ruston
    NR12 9AA Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Secretary38399120002
    YOUNGS, Paul Francis
    Miander
    Sylvan Way Blofield Heath
    NR13 4QL Norwich
    Secrétaire
    Miander
    Sylvan Way Blofield Heath
    NR13 4QL Norwich
    British15538270002
    GRINT, Anthony James
    42 Mountfield Avenue
    Hellesdon
    NR6 5HW Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    42 Mountfield Avenue
    Hellesdon
    NR6 5HW Norwich
    Norfolk
    BritishPrinter15538280001
    GRINT, Robert Melvin
    66 Reepham Road
    NR6 5LT Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    66 Reepham Road
    NR6 5LT Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director32221370001
    HANNER, David John
    60 High House Avenue
    NR18 0JN Wymondham
    Norfolk
    Administrateur
    60 High House Avenue
    NR18 0JN Wymondham
    Norfolk
    BritishProduction Director37118780001
    HEWITT, Bernard Keith
    The Flat
    Langley Grange Langley
    Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Flat
    Langley Grange Langley
    Norwich
    Norfolk
    BritishPrinter15538290001
    METCALF, Andrew John
    115 Plantation Road
    Hellesdon
    NR6 5RH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    115 Plantation Road
    Hellesdon
    NR6 5RH Norwich
    Norfolk
    BritishPrinter15538250001
    MOSS, Peter John
    117 Kipling Way
    IP14 1TS Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    117 Kipling Way
    IP14 1TS Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritishSales Director37118680001
    READ, Edward Julian
    108 Trafford Road
    NR1 2QR Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    108 Trafford Road
    NR1 2QR Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCommercial Director37118600001
    YOUNGS, Ian David
    Corner Barn
    Chapel Road East Ruston
    NR12 9AA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Corner Barn
    Chapel Road East Ruston
    NR12 9AA Norwich
    Norfolk
    BritishFinancial Director38399120002
    YOUNGS, Paul Francis
    Miander
    Sylvan Way Blofield Heath
    NR13 4QL Norwich
    Administrateur
    Miander
    Sylvan Way Blofield Heath
    NR13 4QL Norwich
    BritishPrinter15538270002
    YOUNGS, Simon John
    4 Breydeston Cottages
    Blofield
    NR13 4LN Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    4 Breydeston Cottages
    Blofield
    NR13 4LN Norwich
    Norfolk
    BritishEstimator48223750001
    YOUNGS, Stanley Francis Alfred
    Cuttons Corner
    Hemblington
    NR13 4PS Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Cuttons Corner
    Hemblington
    NR13 4PS Norwich
    Norfolk
    BritishPrinter12578980001
    YOUNGS, Tamara Lynn
    Miander
    Sylvan Way, Blofield
    NR13 4QL Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Miander
    Sylvan Way, Blofield
    NR13 4QL Norwich
    Norfolk
    BritishAccountant69540110001
    YOUNGS, Valerie Patricia
    Homefields Cuttons Corner
    Hemblington
    NR13 4PS Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Homefields Cuttons Corner
    Hemblington
    NR13 4PS Norwich
    Norfolk
    BritishSecretary15538260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Michael Kevin Grapes
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    06 avr. 2016
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Russell David Healey
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    06 avr. 2016
    Gapton Hall Industrial Estate
    NR31 0NL Great Yarmouth
    Gapton Hall Road
    Norfolk
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    GALLPEN PRESS LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2005
    Livré le 21 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 24 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the plant and machinery vehicles computers and other equipment being the agfa apogee X45 e semi automatic (serial no 105). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 24 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 10 juil. 2000
    Livré le 12 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 30 mai 1995
    Livré le 02 juin 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of chattel mortgage
    Créé le 28 juin 1993
    Livré le 30 juin 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease agreement
    Brèves mentions
    1985 heidelberg mozp printing press serial no.606738. 1990 heidelberg single colour gto printing press serial no.702046.
    Personnes ayant droit
    • Close Asset Finance Limited
    Transactions
    • 30 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 04 juin 1992
    Livré le 10 juin 1992
    En cours
    Montant garanti
    £11000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brèves mentions
    Serial nos 456.000.00 249 scantext 2030 ddc imagesetter.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 10 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 11 déc. 1989
    Livré le 13 déc. 1989
    En cours
    Montant garanti
    £90,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    See schedule attached to form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 30 juin 1989
    Livré le 12 juil. 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0