GALLPEN PRESS LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
Nom de la société | GALLPEN PRESS LIMITED(THE) |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00581255 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?
Adresse du siège social | Starling Road Norwich NR3 3EL Norfolk |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Russell Healey en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Notification de Michael Grapes en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Russell David Healey le 05 avr. 2017 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Kevin Grapes le 05 avr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell David Healey le 05 avr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Russell David Healey le 19 juin 2016 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Russell David Healey le 19 juin 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
D éclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEALEY, Russell David | Secrétaire | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | British | Company Director | 37791180001 | |||||
GRAPES, Michael Kevin | Administrateur | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | United Kingdom | British | Travel Agent | 13902740004 | ||||
HEALEY, Russell David | Administrateur | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | England | British | Accountant | 37791180002 | ||||
CATCHPOLE, Linnie | Secrétaire | 514 Hall Road NR4 6NQ Norwich Norfolk | British | Accountant | 35278370001 | |||||
METCALF, Andrew John | Secrétaire | 115 Plantation Road Hellesdon NR6 5RH Norwich Norfolk | British | 15538250001 | ||||||
YOUNGS, Ian David | Secrétaire | Corner Barn Chapel Road East Ruston NR12 9AA Norwich Norfolk | British | Company Secretary | 38399120002 | |||||
YOUNGS, Paul Francis | Secrétaire | Miander Sylvan Way Blofield Heath NR13 4QL Norwich | British | 15538270002 | ||||||
GRINT, Anthony James | Administrateur | 42 Mountfield Avenue Hellesdon NR6 5HW Norwich Norfolk | British | Printer | 15538280001 | |||||
GRINT, Robert Melvin | Administrateur | 66 Reepham Road NR6 5LT Norwich Norfolk | British | Company Director | 32221370001 | |||||
HANNER, David John | Administrateur | 60 High House Avenue NR18 0JN Wymondham Norfolk | British | Production Director | 37118780001 | |||||
HEWITT, Bernard Keith | Administrateur | The Flat Langley Grange Langley Norwich Norfolk | British | Printer | 15538290001 | |||||
METCALF, Andrew John | Administrateur | 115 Plantation Road Hellesdon NR6 5RH Norwich Norfolk | British | Printer | 15538250001 | |||||
MOSS, Peter John | Administrateur | 117 Kipling Way IP14 1TS Stowmarket Suffolk | England | British | Sales Director | 37118680001 | ||||
READ, Edward Julian | Administrateur | 108 Trafford Road NR1 2QR Norwich Norfolk | England | British | Commercial Director | 37118600001 | ||||
YOUNGS, Ian David | Administrateur | Corner Barn Chapel Road East Ruston NR12 9AA Norwich Norfolk | British | Financial Director | 38399120002 | |||||
YOUNGS, Paul Francis | Administrateur | Miander Sylvan Way Blofield Heath NR13 4QL Norwich | British | Printer | 15538270002 | |||||
YOUNGS, Simon John | Administrateur | 4 Breydeston Cottages Blofield NR13 4LN Norwich Norfolk | British | Estimator | 48223750001 | |||||
YOUNGS, Stanley Francis Alfred | Administrateur | Cuttons Corner Hemblington NR13 4PS Norwich Norfolk | British | Printer | 12578980001 | |||||
YOUNGS, Tamara Lynn | Administrateur | Miander Sylvan Way, Blofield NR13 4QL Norwich Norfolk | British | Accountant | 69540110001 | |||||
YOUNGS, Valerie Patricia | Administrateur | Homefields Cuttons Corner Hemblington NR13 4PS Norwich Norfolk | British | Secretary | 15538260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GALLPEN PRESS LIMITED(THE) ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Michael Kevin Grapes | 06 avr. 2016 | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Russell David Healey | 06 avr. 2016 | Gapton Hall Industrial Estate NR31 0NL Great Yarmouth Gapton Hall Road Norfolk England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
GALLPEN PRESS LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 12 juil. 2005 Livré le 21 juil. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 23 déc. 2004 Livré le 24 déc. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the plant and machinery vehicles computers and other equipment being the agfa apogee X45 e semi automatic (serial no 105). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 23 déc. 2004 Livré le 24 déc. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 10 juil. 2000 Livré le 12 juil. 2000 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 30 mai 1995 Livré le 02 juin 1995 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of chattel mortgage | Créé le 28 juin 1993 Livré le 30 juin 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease agreement | |
Brèves mentions 1985 heidelberg mozp printing press serial no.606738. 1990 heidelberg single colour gto printing press serial no.702046. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 04 juin 1992 Livré le 10 juin 1992 | En cours | Montant garanti £11000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Brèves mentions Serial nos 456.000.00 249 scantext 2030 ddc imagesetter. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 11 déc. 1989 Livré le 13 déc. 1989 | En cours | Montant garanti £90,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions See schedule attached to form 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 30 juin 1989 Livré le 12 juil. 1989 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0