LOCKEY BROS. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOCKEY BROS. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00587561
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOCKEY BROS. LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LOCKEY BROS. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ey
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LOCKEY BROS. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour LOCKEY BROS. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Jayne Mary Worden en tant que directeur le 11 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2019

    10 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O 3rd Floor, Radley Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW à C/O Ey 1 More London Place London SE1 2AF le 21 févr. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 janv. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Gregory Pratt en tant que secrétaire le 03 juin 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Roger Clive Best en tant que directeur le 03 juin 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2016

    État du capital au 04 févr. 2016

    • Capital: GBP 7,973
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Justin Paul David Stead en tant qu'administrateur le 07 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Xavier Marie Olivier Simonet en tant que directeur le 08 mai 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    AA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 janv. 2015

    État du capital au 22 janv. 2015

    • Capital: GBP 7,973
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O 6Th Floor, Radley + Co Greater London House Mornington Crescent Hampstead Road London NW1 7QX à Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW le 30 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2013

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 févr. 2014

    État du capital au 05 févr. 2014

    • Capital: GBP 7,973
    SH01

    Nomination de Mrs Jayne Mary Worden en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Xavier Marie Olivier Simonet en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Pelham Allen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de LOCKEY BROS. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEAD, Justin Paul David
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    Administrateur
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    EnglandAmerican204126530001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Secrétaire
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    British67243220003
    BURROWS, Simon Glyn
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    Secrétaire
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    British151991020001
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    MYERS, Philip Joseph
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    Secrétaire
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    British4749710002
    PRATT, Gregory
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Secrétaire
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    167195420001
    ALLEN, Pelham Brian
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish166398180001
    BEST, Roger Clive
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Administrateur
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish114728210001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Administrateur
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Administrateur
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish67243220004
    BURROWS, Simon Glyn
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    Administrateur
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    United KingdomBritish151991020001
    BURROWS, Victor George Charles
    3 Jennings Wood (Off Turpins Ride)
    AL6 Welwyn
    Herts
    Administrateur
    3 Jennings Wood (Off Turpins Ride)
    AL6 Welwyn
    Herts
    British33024950001
    DAVIES, Joyce
    121 Blythway
    Haldens
    AL7 1DL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    121 Blythway
    Haldens
    AL7 1DL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British82051110001
    ENEVOLDSON, Karl Thyge
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    Administrateur
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    British87906250001
    GAEDE, Sven Willi Swithin
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Administrateur
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish122640470001
    HARDER, Lowell Judith
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    Administrateur
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    UkAustralian26244220001
    HOWELL, Christopher Rodney
    56 Kinloch Drive
    NW9 7LH London
    Administrateur
    56 Kinloch Drive
    NW9 7LH London
    British16548940001
    LOCKEY, Eric Bertram
    310 Knightsfield
    AL8 7NQ Welwyn Garden City
    Herts
    Administrateur
    310 Knightsfield
    AL8 7NQ Welwyn Garden City
    Herts
    British33024960001
    LOCKEY, Peter
    9 New Road
    Digswell
    AL6 0AE Welwyn
    Herts
    Administrateur
    9 New Road
    Digswell
    AL6 0AE Welwyn
    Herts
    EnglandBritish33024970001
    LOCKEY, Timothy
    40 The Green
    Stotfold
    SG5 4DG Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    40 The Green
    Stotfold
    SG5 4DG Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish92810850001
    MYERS, Philip Joseph
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    Administrateur
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    British4749710002
    RODRIGUES, Selwyn Mario Pius
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    Administrateur
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    British78514760004
    SIMONET, Xavier Marie Olivier
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Administrateur
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandFrench184753700001
    WARNER, Alan Mark
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    Administrateur
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    United KingdomBritish119324870001
    WORDEN, Jayne Mary
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    Administrateur
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    United KingdomBritish109333140001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LOCKEY BROS. LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    06 avr. 2016
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2573819
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LOCKEY BROS. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 12 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 28 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alan Mark Warner, Malcolm Warner, Christopher Howell and Peter Myers
    Transactions
    • 28 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 28 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lowell Judith Harder
    Transactions
    • 28 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 févr. 1995
    Livré le 20 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 04 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    Transactions
    • 04 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1992
    Livré le 08 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 28, the observatory, high street, slough, berkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 août 1992
    Livré le 13 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 28, the observatory, high street, slough, berkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 mai 1987
    Livré le 27 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 39, the grafton centre, cambridge, cambridgeshire. Title no. Cb 67180.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 mai 1987
    Livré le 21 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    92, queensway stevenage, hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 mai 1987
    Livré le 21 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    45, howardsgate, welwyn garden city, hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LOCKEY BROS. LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2018Commencement of winding up
    12 févr. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    practitioner
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    practitioner
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0