CARILLION INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CARILLION INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00590213 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARILLION INTERNATIONAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARILLION INTERNATIONAL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour CARILLION INTERNATIONAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Francis George le 01 déc. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Timothy Francis George le 01 déc. 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 01 déc. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard John Adam le 09 août 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Birch Street Wolverhampton West Midlands WV1 4HY le 26 juil. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard John Adam le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2006 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CARILLION INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, Timothy Francis | Secrétaire | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| ADAM, Richard John | Administrateur | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| GEORGE, Timothy Francis | Administrateur | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 24075160004 | |||||
| MILLS, Lee James | Administrateur | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Secrétaire | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Secrétaire | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Secrétaire | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| CARILLION CONSTRUCTION NOMINEES LIMITED | Secrétaire | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton | 79704800001 | |||||||
| BRIDGEWOOD, Edward James | Administrateur | 36 High Meadows Compton WV6 8PH Wolverhampton West Midlands | British | 8104890001 | ||||||
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Administrateur | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| HAMMOND, Nicholas Warwick | Administrateur | 16 Anderton Close B74 2RJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 12402730001 | ||||||
| HOARE, David Reginald | Administrateur | 10 St Michaels Close ST19 5AD Penkridge Staffordshire | Civil Engineer | 10396820001 | ||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Administrateur | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Administrateur | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| PALMER, Martyn Charles | Administrateur | Woodlands Church End, Bishampton WR10 2LT Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | 203408350001 | |||||
| PELLARD, Brian | Administrateur | 33 Wyvern Road B74 2PS Sutton Coldfield West Midlands | British | 33408310001 | ||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Administrateur | Sycamore Court Gawsworth New Hall Church Lane SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 55479560002 | ||||||
| WATERS, Gordon Arthur Ivan | Administrateur | 10 Corbett Avenue WR9 7BE Droitwich Worcestershire | British | 12413270001 | ||||||
| WATKINSON, Douglas Harold | Administrateur | Fairfield House 6 Regents Walk SL5 9JQ Ascot Berkshire | British | 70514320001 | ||||||
| CARILLION NOMINEES LIMITED | Administrateur | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton | 79704880001 |
CARILLION INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Instrument of charge. | Créé le 26 juin 1972 Livré le 11 juil. 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing debenture stock of tarmac LTD secured by a trust deed dated 5/10/64 & deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions By way of a floating charge see doc. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fifth supplemental trust deed | Créé le 26 juin 1972 Livré le 07 juil. 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti Securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £2,750,000 | |
Brèves mentions First floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Third supplemental trust deed | Créé le 16 déc. 1968 Livré le 30 déc. 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti Securing debenture stock of tarmac derby LTD amounting to £7,625,725. inclusive of £ 5,000,000 secured by a trust deed dated 5TH october 1964 and deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0