ARC OVERSEAS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARC OVERSEAS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00593123
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARC OVERSEAS LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe ARC OVERSEAS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Steelpark Trading Estate
    Steelpark Way
    WV11 3BF Wolverhampton
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARC OVERSEAS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    METALRAX OVERSEAS HOLDINGS LIMITED22 juil. 200922 juil. 2009
    MRX GROUP SALES LIMITED31 mai 200631 mai 2006
    METALRAX GROUP SALES LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    PRIORY DOOR AND ENGINEERING CO.,LIMITED (THE)05 nov. 195705 nov. 1957

    Quels sont les derniers comptes de ARC OVERSEAS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour ARC OVERSEAS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital au 18 mai 2021

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 17 mai 2021

    • Capital: GBP 35,236
    3 pagesSH01

    Satisfaction de la charge 005931230010 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 09 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2018

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 8 C/O Cooper Coated Coil Limited Unit 8, Planetary Industrial Estate Wolverhampton West Midlands United Kingdom à 4 Steelpark Trading Estate Steelpark Way Wolverhampton WV11 3BF le 11 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Arc Specialist Engineering Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 janv. 2019

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ews (Manufacturing) Limited Ews Headway Road Wolverhampton WV10 6PZ England à 8 C/O Cooper Coated Coil Limited Unit 8, Planetary Industrial Estate Wolverhampton West Midlands le 03 juil. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew John Richardson en tant que directeur le 23 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kevin David Tranter en tant qu'administrateur le 23 mars 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2017

    11 pagesAA

    Satisfaction de la charge 005931230009 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    38 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de ARC OVERSEAS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TRANTER, Kevin David
    Steelpark Trading Estate
    Steelpark Way
    WV11 3BF Wolverhampton
    4
    England
    Administrateur
    Steelpark Trading Estate
    Steelpark Way
    WV11 3BF Wolverhampton
    4
    England
    United KingdomBritishGroup Managing Director244570860001
    FARRIMOND, Darren James
    5 Marsh Way
    Catshill
    B61 0JD Bromsgrove
    Secrétaire
    5 Marsh Way
    Catshill
    B61 0JD Bromsgrove
    British96411190001
    JONES, Terry Ryan
    5 Dodford Court Fockbury Lane
    Dodford
    B61 9AP Bromsgrove
    Worcestershire
    Secrétaire
    5 Dodford Court Fockbury Lane
    Dodford
    B61 9AP Bromsgrove
    Worcestershire
    British12676600001
    LONGLEY, Nicholas
    Old Rectory Lane
    Alvechurch
    B48 7SX Birmingham
    Rectory Court
    West Midlands
    England
    Secrétaire
    Old Rectory Lane
    Alvechurch
    B48 7SX Birmingham
    Rectory Court
    West Midlands
    England
    British146888980001
    STOCK, Michael John
    WR9 7NH Tibberton
    Foredraught House
    Worcs
    Secrétaire
    WR9 7NH Tibberton
    Foredraught House
    Worcs
    British129726080001
    ARBUTHNOT, Richard
    101 Dorridge Road
    Dorridge
    B93 8BS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    101 Dorridge Road
    Dorridge
    B93 8BS Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director67470540001
    BROOK-CARTER, Ronald Hedley
    Longacre Rowney Green Lane
    Alvechurch
    B48 7QF Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Longacre Rowney Green Lane
    Alvechurch
    B48 7QF Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director12720220001
    CAMPION, William Ian
    11 Shireburn Road
    Formby
    L37 1LR Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    11 Shireburn Road
    Formby
    L37 1LR Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director1672810001
    DOWNS, Lawrence James
    7 Belton Close
    Hockley Heath
    B94 6QU Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    7 Belton Close
    Hockley Heath
    B94 6QU Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director74478840001
    GREEN, Caroline Inez
    Old Rectory Lane
    Alvechurch
    B48 7SX Birmingham
    Rectory Court
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Old Rectory Lane
    Alvechurch
    B48 7SX Birmingham
    Rectory Court
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishFinance Director174414810001
    JONES, Pascale Anne Dominique
    4 The Brambles
    SY5 9AT Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    4 The Brambles
    SY5 9AT Shrewsbury
    Salop
    BritishDirector115699660001
    MACKENZIE, Alan James
    2 Newton Square
    Great Barr
    B43 6DY Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    2 Newton Square
    Great Barr
    B43 6DY Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director1672820001
    MOORE, Eric Stanley
    18 Grove Vale Avenue
    Great Barr
    B43 6BZ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    18 Grove Vale Avenue
    Great Barr
    B43 6BZ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director1672830001
    RICHARDSON, Andrew John
    c/o Ews (Manufacturing) Limited
    Headway Road
    WV10 6PZ Wolverhampton
    Ews
    England
    Administrateur
    c/o Ews (Manufacturing) Limited
    Headway Road
    WV10 6PZ Wolverhampton
    Ews
    England
    EnglandBritishDirector132142760002
    SMITH, Michael John Bennell
    Ardath Road
    Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    Administrateur
    Ardath Road
    Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    EnglandBritishDirector61926400002
    STOCK, Michael John
    WR9 7NH Tibberton
    Foredraught House
    Worcs
    Administrateur
    WR9 7NH Tibberton
    Foredraught House
    Worcs
    EnglandBritishDirector129726080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ARC OVERSEAS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cooper Coated Coil Management Limited
    Steelpark Trading Estate
    Steelpark Way
    WV11 3BF Wolverhampton
    4
    England
    06 avr. 2016
    Steelpark Trading Estate
    Steelpark Way
    WV11 3BF Wolverhampton
    4
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Companies Act
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrement08453509
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ARC OVERSEAS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 juil. 2017
    Livré le 08 août 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mobeus Equity Partners Iv LP Acting by Its General Partner Mobeus Iv Gp LLP
    Transactions
    • 08 août 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 sept. 2015
    Livré le 10 sept. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Stock pledge agreement
    Créé le 02 avr. 2013
    Livré le 12 avr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the any member of the group and by each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in and to all of the shares being all of the shares of the capital stock of the issuer and all dividends, distributions, cash, warrants, rights, options, instruments, securities and other property or proceeds see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2013
    Livré le 10 avr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 10 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Stock pledge agreement
    Créé le 02 avr. 2013
    Livré le 06 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the shares of the issuer all other property in substitution for or in addition to the pledged shares any other property delivered to or in the possession or custody of the company and all proceeds of the collateral see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Metalsteel Jersey Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2013
    Livré le 06 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrower to mjl on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Metalsteel Jersey Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 05 nov. 2009
    Livré le 17 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Security interest in 1,000 shares issued by metalrax holdings inc. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Security Agent)
    Transactions
    • 17 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share pledge agreement
    Créé le 05 nov. 2009
    Livré le 13 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the shares of stock and other securities certificates and/or instruments representing such shares of stock see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Metalrax Group Pension Trustees Limited as Trustee of the Metalrax Group PLC Pension and Life Assurance Plan
    Transactions
    • 13 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 oct. 2009
    Livré le 21 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 21 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A composite guarantee and debenture
    Créé le 12 oct. 2009
    Livré le 19 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Metalrax Group Pension Trustees Limited as Trustees of the Metalrax Group PLC Pension and Life Assurance Plan
    Transactions
    • 19 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0