AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00595129 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED ?
| Adresse du siège social | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2021 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2022 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 juin 2022 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 08 juil. 2022 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 juin 2021 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauration par ordonnance du tribunal | 2 pages | AC92 | ||||||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de S & J Registrars Limited en tant que secrétaire le 30 juin 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Rowell le 16 mars 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Ryan Ronald Dale en tant que secrétaire le 18 déc. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Matthew Deakin en tant que directeur le 30 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Notification de Avery Weigh-Tronix International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Ufland en tant que directeur le 13 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 20 déc. 2016
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALE, Ryan Ronald | Secrétaire | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | 241474960001 | |||||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| ROWELL, Stephen James | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | United Kingdom | British | 208316380001 | |||||||||
| FOGARTY, Robert Joseph | Secrétaire | April Cottage Manor Lane Little Comberton WR10 3ER Pershore Worcestershire | British | 17437720002 | ||||||||||
| PENGELLY, Ian Philip | Secrétaire | 5 The Close New Road, Burton Lazars LE14 2UX Melton Mowbray Leicestershire | British | 77988000001 | ||||||||||
| S & J REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England |
| 132600000001 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| BARWOOD, Andrew Richard | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | United Kingdom | British | 150123090001 | |||||||||
| BITTLESTON, Timothy Steven | Administrateur | 64 Burton Old Road West Hawthorn House WS13 6EN Lichfield Staffordshire | British | 54626420001 | ||||||||||
| BOWE, Gerald Grant | Administrateur | 85 Pasquaney Lane Bridgewater Nh 03222 Usa | American | 86912720003 | ||||||||||
| BRANSTON, Peter | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | United Kingdom | British | 104888060001 | |||||||||
| CAFFYN, Andrew David | Administrateur | High Street OX11 9JE Upton Brookside Oxfordshire | United Kingdom | British | 192849650001 | |||||||||
| CASTLE, David Rayner | Administrateur | 1363 Third Line Road Lakefield Ontario K01 2ho Canada | American | 86859030002 | ||||||||||
| COOPER, Timothy John | Administrateur | 38 Grosvenor Close Four Oaks Sutton Coalfield B75 6RP Birmingham West Midlands | British | 145948190001 | ||||||||||
| CRAMER, Carl, Mr. | Administrateur | 2 Little Dormers South Park Crescent SL9 8HJ Gerrards Cross | United Kingdom | British | 92710960001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | United Kingdom | British | 146225080003 | |||||||||
| FAUSET, Ian David | Administrateur | 7 Adelaide Road KT12 1NB Walton On Thames Surrey | British | 29036880001 | ||||||||||
| GODDARD, Richard Dudley | Administrateur | Paddock End Coney Green Collingham NG23 7QT Newark Nottinghamshire | Uk | British | 155978280001 | |||||||||
| GRAHAM, Brian | Administrateur | Chateauvin Church Road Grafham PE18 0BB Huntingdon Cambridgeshire | British | 37644470001 | ||||||||||
| GRANT, Peter William | Administrateur | 51 Old Croft Road Walton-On-The-Hill ST17 0NL Stafford Staffordshire | British | 33906820001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, Robert Mark | Administrateur | 4 Hillcrest NG25 0AQ Southwell Nottinghamshire | British | 45441890001 | ||||||||||
| GUNNING, Laurence Patrick | Administrateur | Bushey Cottage High Street, Chipstead TN13 2RW Sevenoaks Kent | Irish | 45213690002 | ||||||||||
| HASSALL, Michael | Administrateur | 1 Hornbeam Drive CW8 2GA Hartford Cheshire | British | 48866820001 | ||||||||||
| HIRST, Elliot | Administrateur | 3 St Margarets View LS8 1RX Leeds | British | 37951090004 | ||||||||||
| KIRKMAN, Anthony Terence | Administrateur | 3 Cawdon Grove Dorridge B93 8EA Solihull West Midlands | British | 41435170001 | ||||||||||
| PENGELLY, Ian Philip | Administrateur | 5 The Close New Road, Burton Lazars LE14 2UX Melton Mowbray Leicestershire | Great Britain | British | 77988000001 | |||||||||
| SAUNDERS, Gillian Margaret | Administrateur | Old Conifers 3 Pheasant Walk, Loggerheads TF9 2QZ Market Drayton Shropshire | British | 74696800001 | ||||||||||
| SCAHILL, David Nicholas | Administrateur | Willow Tree Cottage Slade Lane, Ash GU12 6DY Aldershot Hampshire | British | 66661720001 | ||||||||||
| SCOTT, Michael John | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | United Kingdom | British | 170446190001 | |||||||||
| SLAUGHTER, Ian Richard Holder | Administrateur | 25 Matham Road KT8 0SX East Molesey Surrey | United Kingdom | British | 39851430003 | |||||||||
| SOAMES, Rupert Christopher | Administrateur | Ridge Barn Farm House Ridgebarn Lane, Cuddington HP18 0AE Aylesbury Buckinghamshire | Scotland | British | 86671010001 | |||||||||
| STEYAERT, Michael Emiel Marie | Administrateur | A Musschestraat 46 9000 Gent FOREIGN Belgium | Belgian | 38276600001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Administrateur | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Administrateur | Foundry Lane Smethwick B66 2LP West Midlands | England | British | 161583570001 | |||||||||
| WAELEND, Derek Alfred | Administrateur | 227 Warwick Road CV8 1FB Kenilworth Warwickshire | British | 29036870001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Weigh-Tronix International Limited | 06 avr. 2016 | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0