ENVOPAK GROUP
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ENVOPAK GROUP |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 00596706 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ENVOPAK GROUP ?
| Adresse du siège social | 99 Gresham Street London EC2V 7NG |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ENVOPAK GROUP ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour ENVOPAK GROUP ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 3 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 nov. 2011 au 31 déc. 2011 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2010 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ola Tricia Aramita Barreto-Morley le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Matthew Deakin le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Edward Ufland le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Giles Hudson le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire S & J Registrars Limited le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Udall en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Philip Matthew Deakin en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2008 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2007 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 30 nov. 2006 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ENVOPAK GROUP ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 161583790001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| HOULDSWORTH, Raymond | Secrétaire | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | 28059370001 | ||||||||||
| PIPER, Maurice George | Secrétaire | 8 Chestnut Lane Matfield TN12 7JL Tonbridge Kent | British | 8141120001 | ||||||||||
| PROBERT, Clive Michael Douglas | Secrétaire | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | 10804410001 | ||||||||||
| WICKETT, Edna May | Secrétaire | 55 Ladbrooke Crescent Albany Park DA14 4RU Sidcup Kent | British | 36891520001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Secrétaire | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 | ||||||||||
| ARTHUR, Frank Henry | Administrateur | Well Hill Cottage Well Hill BR6 7RL Chelsfield Kent | England | British | 8141130001 | |||||||||
| BANGLE, Alfred Richard George | Administrateur | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | 20981040001 | ||||||||||
| BANGLE, Alfred Richard George | Administrateur | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | 20981040001 | ||||||||||
| BLACK, Stephen | Administrateur | Les Vielles Terres Havelet GY1 1AZ St Peter Port Guernsey | British | 73554610001 | ||||||||||
| CAMERON, Ian Donald | Administrateur | The Old Rectory Peasemore RG16 0JH Newbury Berkshire | British | 13521010001 | ||||||||||
| HENSHAW, Robert Charles Mayon | Administrateur | 89 Sherbrooke Road SW6 7QL London | British | 66661330001 | ||||||||||
| HOLLINGSWORTH, Roger Colin | Administrateur | 97 Copse Avenue BR4 9NW West Wickham Kent | British | 20963700001 | ||||||||||
| HOULDSWORTH, Raymond | Administrateur | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | 28059370001 | ||||||||||
| KIRBY, Robert Bernard | Administrateur | 1 Manor House Drive Crawford WN8 9QZ Upholland Lancashire | England | British | 221394890001 | |||||||||
| LEWIS, Thomas Arwyn | Administrateur | 35 Clos Glanlliw Pontlliw SA4 9DW Swansea West Glamorgan | British | 65122490001 | ||||||||||
| O'DOHERTY, Jean Crichton | Administrateur | 2g The Glebe Blackheath SE3 9TT London | England | British | 13964410001 | |||||||||
| PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir | Administrateur | Kings Walden Bury SG4 8JU Hitchin Herts | England | British | 5324930001 | |||||||||
| PROBERT, Clive Michael Douglas | Administrateur | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | 10804410001 | ||||||||||
| REED, Peter John | Administrateur | 116 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | 21740620001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Administrateur | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| UDELHOFEN, Mark James | Administrateur | 771 Revere Road Glen Ellyn Illinois 60137 Usa | American | 84364350001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Administrateur | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 |
ENVOPAK GROUP a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 13 nov. 2000 Livré le 16 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 22 juil. 1998 Livré le 25 juil. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 30 juin 1995 Livré le 06 juil. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 02 mars 1993 Livré le 06 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 31 mars 1987 Livré le 03 avr. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 16 mars 1987 Livré le 20 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 29 sept. 1986 Livré le 20 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 juil. 1970 Livré le 29 juil. 1970 | Totalement satisfaite | Montant garanti £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD. | |
Brèves mentions Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 14 juin 1968 Livré le 28 juin 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 06 janv. 1965 Livré le 07 janv. 1965 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc | |
Brèves mentions Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0