ENVOPAK GROUP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENVOPAK GROUP
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 00596706
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENVOPAK GROUP ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ENVOPAK GROUP ?

    Adresse du siège social
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ENVOPAK GROUP ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENVOPAK LIMITED08 janv. 195808 janv. 1958

    Quels sont les derniers comptes de ENVOPAK GROUP ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour ENVOPAK GROUP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    3 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 30 nov. 2011 au 31 déc. 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 nov. 2011

    État du capital au 30 nov. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ola Tricia Aramita Barreto-Morley le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Matthew Deakin le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Edward Ufland le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Giles Hudson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire S & J Registrars Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    Cessation de la nomination de Gavin Udall en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Philip Matthew Deakin en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 30 nov. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 nov. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 nov. 2006

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de ENVOPAK GROUP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Administrateur
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish87558180001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Secrétaire
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Secrétaire
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    WICKETT, Edna May
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    British36891520001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Secrétaire
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001
    ARTHUR, Frank Henry
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    Administrateur
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish8141130001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Administrateur
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Administrateur
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Administrateur
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    British73554610001
    CAMERON, Ian Donald
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    British13521010001
    HENSHAW, Robert Charles Mayon
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    Administrateur
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    British66661330001
    HOLLINGSWORTH, Roger Colin
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    Administrateur
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    British20963700001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Administrateur
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    KIRBY, Robert Bernard
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    Administrateur
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    EnglandBritish221394890001
    LEWIS, Thomas Arwyn
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    British65122490001
    O'DOHERTY, Jean Crichton
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    Administrateur
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    EnglandBritish13964410001
    PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    Administrateur
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    EnglandBritish5324930001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    REED, Peter John
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Administrateur
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British21740620001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UDELHOFEN, Mark James
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    Administrateur
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    American84364350001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001

    ENVOPAK GROUP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2000
    Livré le 16 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 juil. 1998
    Livré le 25 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 juin 1995
    Livré le 06 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1993
    Livré le 06 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 mars 1987
    Livré le 03 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 08 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 16 mars 1987
    Livré le 20 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 08 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 sept. 1986
    Livré le 20 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 14 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 1970
    Livré le 29 juil. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD.
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details).
    Personnes ayant droit
    • The Charente Steamship Co LTD
    Transactions
    • 29 juil. 1970Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 14 juin 1968
    Livré le 28 juin 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1968Enregistrement d'une charge
    • 08 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 06 janv. 1965
    Livré le 07 janv. 1965
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1965Enregistrement d'une charge
    • 08 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0