GE REAL ESTATE LOANS LIMITED

GE REAL ESTATE LOANS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGE REAL ESTATE LOANS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00606529
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REAL ESTATE LOANS LIMITED18 janv. 201218 janv. 2012
    BISHOPSWOOD PROPERTIES LIMITED18 juin 195818 juin 1958

    Quels sont les derniers comptes de GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Modification des détails de Ge Real Estate (Investment Property Company) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 août 2018

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que secrétaire le 31 janv. 2018

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ à 1 More London Place London SE1 2AF le 15 janv. 2018

    2 pagesAD01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ

    2 pagesAD02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 déc. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    21 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Stewart Girling en tant qu'administrateur le 11 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Damien Ivo Karlov en tant que directeur le 28 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Manager Derek Carter en tant qu'administrateur le 24 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anupam Manchanda en tant que directeur le 02 mars 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2016

    État du capital au 11 avr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Panayot Kostadinov Vasilev en tant que directeur le 18 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Roy Slocombe en tant qu'administrateur le 11 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Neville Bowden en tant que directeur le 13 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Damien Ivo Karlov en tant qu'administrateur le 02 nov. 2015

    2 pagesAP01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 05 août 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Qui sont les dirigeants de GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishPortfolio Manager225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritishDirector225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    Secrétaire
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    BritishLegal Counsel117898690002
    BEWSEY, Martin Roy
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    Secrétaire
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    British88472130001
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    BritishAccountant26039210001
    MANNING, John Ronald
    19 Pinewood Avenue
    TN14 5AE Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    19 Pinewood Avenue
    TN14 5AE Sevenoaks
    Kent
    British29806870001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Secrétaire
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    British55097590003
    WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Secrétaire
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    British85529340001
    ABRAMSON, Christoffer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Administrateur
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    SwedishChief Financial Officer98463110005
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Administrateur
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritishChartered Surveyor38758710002
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Administrateur
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    AmericanController116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant183344960001
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Administrateur
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrishChartered Surveyor90824990003
    CHALLE, Gregoire Marie Philippe
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomFrenchDebt Director183360310001
    COLLETT, Melanie Jacqueline
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor173277230001
    COLLETT, Melanie Jacqueline
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor173277230001
    CONNELLAN, Paul Francis
    7 Spencer Road
    TW7 4BQ Isleworth
    Middlesex
    Administrateur
    7 Spencer Road
    TW7 4BQ Isleworth
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor67336830001
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Administrateur
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritishSurveyor59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Administrateur
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritishChartered Surveyor93124450002
    DELANEY, Martin Peter
    4 Hillside Road
    WD7 7BH Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Hillside Road
    WD7 7BH Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor6499050001
    EDWARDS, Jeremy Colin Gamul
    Dray House Broomrigg Road
    GU13 8LR Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Dray House Broomrigg Road
    GU13 8LR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant225698250001
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor107819460001
    FREE, Nicola
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanking164473860001
    GATISS, Ian William
    Coleridge Road
    CB1 3PH Cambridge
    61
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Coleridge Road
    CB1 3PH Cambridge
    61
    Cambridgeshire
    EnglandBritishAsset Manager95094220003
    GILBERT, Donald Peter
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Risk, Uk158328310001
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAsset Manager94095660004
    HUNTER, Randall Leon
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomAmericanRisk Director173280880001
    JEVNE, Anne
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    Administrateur
    26 Amner Road
    SW11 6AA London
    NorwegianChartered Surveyor126577610001
    JEVNE, Anne
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Administrateur
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    NorwegianAsset Manager106807190001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrishVat, Finance Operations Manager202318870001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Administrateur
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    BritishAccountant26039210001
    LEE, David Robert
    2 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    BritishAccountant76032910002
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Administrateur
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritishChartered Surveyor96177720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    03 juin 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05514488
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GE REAL ESTATE LOANS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 18 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a chichester house 272-282 high holborn london WC2 t/no 430902. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 18 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a west side of west gate leeds k/a 1 park lane leeds t/no WYK550759. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 18 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a kingston house estate portsmouth road surbiton surrey and land and buildings on the south east side of portsmouth road surbiton surrey t/nos SY694988 and SY694989. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed security document
    Créé le 16 déc. 2002
    Livré le 23 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Present real property, other assets and assignments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 23 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juil. 1998
    Livré le 04 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or pillar property developments limited (together the borrowers) to the chargee under or in connection with the facility agreement dated 22ND july 1998
    Brèves mentions
    F/H property being land on the south east side of cutenhoe road luton t/no.BD120294 and also any fixed machinery buildings or other erections and fixtures and fittings. By way of first fixed charge any sum paid out on any insurance policy, any deposit, all rents, any cash deposit. Floating charge over all undertaking property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 04 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1998
    Livré le 26 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The olbigations of the company to the chargee under an option agreement of even date in respect of the sale and purchase of the property thereby charged including the obligation of the company to repay £500,000 to the chargee in the event of non exercise of the option
    Brèves mentions
    F.h st clements house 33 35 and 37 church street walton on thames t/n SY337136.
    Personnes ayant droit
    • Readystart Associates Limited
    Transactions
    • 26 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 déc. 1997
    Livré le 16 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £600,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All that f/h property at walton on thames town centre site under t/nos.SY400665, SY515430, SY588597, SY66634, SY587139, SY529204 (part) and SY131701 (part).
    Personnes ayant droit
    • Readystart Associates Limited
    Transactions
    • 16 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1978
    Livré le 31 mars 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £6,800,000 advanced to haslemere estates LTD.
    Brèves mentions
    3 craven hill paddington westminster.
    Personnes ayant droit
    • Natcams Nominees LTD.
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1978Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1978
    Livré le 31 mars 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,200,000 advanced to haslemere estates LTD.
    Brèves mentions
    170 westminster bridge rd lambeth london.
    Personnes ayant droit
    • Natcams Nominees LTD.
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1978Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 06 févr. 1962
    Livré le 16 févr. 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc.
    Brèves mentions
    1. haslemere road, hornsey, title no. Mx 177849.
    Personnes ayant droit
    • Westminster Bk. LTD
    Transactions
    • 16 févr. 1962Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 09 mai 1961
    Livré le 10 mai 1961
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc.
    Brèves mentions
    Leith house, gresham st. London title no. 318166.
    Personnes ayant droit
    • Westminster Bk. LTD
    Transactions
    • 10 mai 1961Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 15 janv. 1960
    Livré le 15 janv. 1960
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000.
    Brèves mentions
    25, augusta gardens, folkestone, kent.
    Personnes ayant droit
    • J K Mannock
    • A Hutchinson
    • Winifred Hutchinson
    Transactions
    • 15 janv. 1960Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 04 nov. 1959
    Livré le 09 nov. 1959
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc.
    Brèves mentions
    48/49 crawford street & 94A seymounr place, london W.1, including all trade & other fixtures present & future.
    Personnes ayant droit
    • Westminster Bank LTD
    Transactions
    • 09 nov. 1959Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GE REAL ESTATE LOANS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 déc. 2017Commencement of winding up
    10 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0