GE REAL ESTATE LOANS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GE REAL ESTATE LOANS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00606529 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Modification des détails de Ge Real Estate (Investment Property Company) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 août 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que directeur le 28 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que secrétaire le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ à 1 More London Place London SE1 2AF le 15 janv. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 21 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Stewart Girling en tant qu'administrateur le 11 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Damien Ivo Karlov en tant que directeur le 28 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Manager Derek Carter en tant qu'administrateur le 24 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anupam Manchanda en tant que directeur le 02 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 24 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Panayot Kostadinov Vasilev en tant que directeur le 18 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Roy Slocombe en tant qu'administrateur le 11 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Neville Bowden en tant que directeur le 13 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Damien Ivo Karlov en tant qu'administrateur le 02 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 05 août 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARTER, Derek | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Portfolio Manager | 225848070001 | ||||
GIRLING, Paul Stewart | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | Director | 225432580001 | ||||
BAMBER, Janine Margaret | Secrétaire | 105 Shepperton Road N1 3DF London | British | Legal Counsel | 117898690002 | |||||
BEWSEY, Martin Roy | Secrétaire | 16 Hawthorne Road BR1 2HH Bromley Kent | British | 88472130001 | ||||||
BROWN, Grace | Secrétaire | 35 Corringham Road Wembley Park HA9 9PX Wembley Middlesex | British | 102074060001 | ||||||
KEARLEY, Andrew Paul | Secrétaire | 12 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | Accountant | 26039210001 | |||||
MANNING, John Ronald | Secrétaire | 19 Pinewood Avenue TN14 5AE Sevenoaks Kent | British | 29806870001 | ||||||
SLOCOMBE, Stephen Roy | Secrétaire | More London Place SE1 2AF London 1 | British | 55097590003 | ||||||
WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons | Secrétaire | Meadow Cottage Hawksfold Lane GU27 3JW Fernhurst Surrey | British | 85529340001 | ||||||
ABRAMSON, Christoffer | Administrateur | 37-39 Abingdon Road Flat 2 W8 6AH London | Swedish | Chief Financial Officer | 98463110005 | |||||
BARTRAM, Christopher John | Administrateur | 15 Trumpington Road CB2 2AJ Cambridge | England | British | Chartered Surveyor | 38758710002 | ||||
BOTHA, Stephanie | Administrateur | 5 Highbridge Wharf Highbridge SE10 9PS London | American | Controller | 116663740001 | |||||
BOWDEN, Matthew Neville | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 183344960001 | ||||
CASEY, Shay Andrew | Administrateur | Flat 3 St Mary Hall 106 Felsham Road SW15 1DQ London | United Kingdom | Irish | Chartered Surveyor | 90824990003 | ||||
CHALLE, Gregoire Marie Philippe | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | French | Debt Director | 183360310001 | ||||
COLLETT, Melanie Jacqueline | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 173277230001 | ||||
COLLETT, Melanie Jacqueline | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 173277230001 | ||||
CONNELLAN, Paul Francis | Administrateur | 7 Spencer Road TW7 4BQ Isleworth Middlesex | British | Chartered Surveyor | 67336830001 | |||||
DEBNEY, Richard Johnathon | Administrateur | 81 Manor Way Blackheath SE3 9XG London | England | British | Surveyor | 59232720003 | ||||
DEL BEATO, Ilaria Jane | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 93124450002 | ||||
DEL BEATO, Ilaria Jane | Administrateur | 33 Gorst Road Battersea SW11 6JB London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 93124450002 | ||||
DELANEY, Martin Peter | Administrateur | 4 Hillside Road WD7 7BH Radlett Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 6499050001 | ||||
EDWARDS, Jeremy Colin Gamul | Administrateur | Dray House Broomrigg Road GU13 8LR Fleet Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 225698250001 | ||||
FELCE, Gary John | Administrateur | 25 Ickwell Road Northill SG18 9AB Biggleswade Bedfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 107819460001 | ||||
FREE, Nicola | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Banking | 164473860001 | ||||
GATISS, Ian William | Administrateur | Coleridge Road CB1 3PH Cambridge 61 Cambridgeshire | England | British | Asset Manager | 95094220003 | ||||
GILBERT, Donald Peter | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Risk, Uk | 158328310001 | ||||
HARRIS, Neil Jason | Administrateur | Pattison Lane Woolstone MK15 0AU Milton Keynes 11 Buckinghamshire | England | British | Asset Manager | 94095660004 | ||||
HUNTER, Randall Leon | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | American | Risk Director | 173280880001 | ||||
JEVNE, Anne | Administrateur | 26 Amner Road SW11 6AA London | Norwegian | Chartered Surveyor | 126577610001 | |||||
JEVNE, Anne | Administrateur | Flat 8 70 Ironmonger Row EC1V 3QR London | Norwegian | Asset Manager | 106807190001 | |||||
KARLOV, Damien Ivo | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Irish | Vat, Finance Operations Manager | 202318870001 | ||||
KEARLEY, Andrew Paul | Administrateur | 12 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | Accountant | 26039210001 | |||||
LEE, David Robert | Administrateur | 2 Thurlow Close SG1 4SD Stevenage Hertfordshire | British | Accountant | 76032910002 | |||||
LEWIS, Martyn Phillips | Administrateur | Wyncroft Ringmore TQ7 4HL Kingsbridge Devon | England | British | Chartered Surveyor | 96177720001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GE REAL ESTATE LOANS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ge Real Estate (Investment Property Company) Limited | 03 juin 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
GE REAL ESTATE LOANS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 16 juin 2003 Livré le 18 juin 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a chichester house 272-282 high holborn london WC2 t/no 430902. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 juin 2003 Livré le 18 juin 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a west side of west gate leeds k/a 1 park lane leeds t/no WYK550759. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 juin 2003 Livré le 18 juin 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a kingston house estate portsmouth road surbiton surrey and land and buildings on the south east side of portsmouth road surbiton surrey t/nos SY694988 and SY694989. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed security document | Créé le 16 déc. 2002 Livré le 23 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Present real property, other assets and assignments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 22 juil. 1998 Livré le 04 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or pillar property developments limited (together the borrowers) to the chargee under or in connection with the facility agreement dated 22ND july 1998 | |
Brèves mentions F/H property being land on the south east side of cutenhoe road luton t/no.BD120294 and also any fixed machinery buildings or other erections and fixtures and fittings. By way of first fixed charge any sum paid out on any insurance policy, any deposit, all rents, any cash deposit. Floating charge over all undertaking property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 févr. 1998 Livré le 26 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The olbigations of the company to the chargee under an option agreement of even date in respect of the sale and purchase of the property thereby charged including the obligation of the company to repay £500,000 to the chargee in the event of non exercise of the option | |
Brèves mentions F.h st clements house 33 35 and 37 church street walton on thames t/n SY337136. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 05 déc. 1997 Livré le 16 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti £600,000 due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All that f/h property at walton on thames town centre site under t/nos.SY400665, SY515430, SY588597, SY66634, SY587139, SY529204 (part) and SY131701 (part). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 29 mars 1978 Livré le 31 mars 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti £6,800,000 advanced to haslemere estates LTD. | |
Brèves mentions 3 craven hill paddington westminster. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 29 mars 1978 Livré le 31 mars 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti £7,200,000 advanced to haslemere estates LTD. | |
Brèves mentions 170 westminster bridge rd lambeth london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 06 févr. 1962 Livré le 16 févr. 1962 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc. | |
Brèves mentions 1. haslemere road, hornsey, title no. Mx 177849. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 09 mai 1961 Livré le 10 mai 1961 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc. | |
Brèves mentions Leith house, gresham st. London title no. 318166. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 15 janv. 1960 Livré le 15 janv. 1960 | Totalement satisfaite | Montant garanti £5,000. | |
Brèves mentions 25, augusta gardens, folkestone, kent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 04 nov. 1959 Livré le 09 nov. 1959 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc. | |
Brèves mentions 48/49 crawford street & 94A seymounr place, london W.1, including all trade & other fixtures present & future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
GE REAL ESTATE LOANS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0