T.H. BROWN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéT.H. BROWN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00608768
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de T.H. BROWN LIMITED ?

    • Exploitation d'entrepôts et de terminaux de stockage pour le transport terrestre (52103) / Transports et stockage

    Où se situe T.H. BROWN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions Business Hive
    13 Dudley Street
    DN31 2AW Grimsby
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de T.H. BROWN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour T.H. BROWN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mars 2021

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 26 South Saint Mary's Gate Grimsby North East Lincolnshire DN31 1LW United Kingdom à C/O Kingsbridge Corporate Solutions Business Hive 13 Dudley Street Grimsby DN31 2AW le 08 avr. 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 mars 2020

    LRESSP

    Période comptable précédente prolongée du 31 juil. 2019 au 31 janv. 2020

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Estate Road 1 South Humberside Industrial Estate Grimsby N.E. Lincolnshire DN31 2TB à 26 South Saint Mary's Gate Grimsby North East Lincolnshire DN31 1LW le 26 févr. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2020 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2018

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 006087680013 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2017

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 févr. 2016

    État du capital au 10 févr. 2016

    • Capital: GBP 20,591
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2015

    État du capital au 17 févr. 2015

    • Capital: GBP 20,591
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2014

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de T.H. BROWN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Anthony Stuart Edlund
    Pantiles,Chapel Lane
    Swallow
    LN7 6DE Lincoln
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Pantiles,Chapel Lane
    Swallow
    LN7 6DE Lincoln
    Lincolnshire
    British3774360001
    BROWN, Martin Glenn
    Vicarage Road,
    Great Carlton,
    LN11 8JP Louth.
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Administrateur
    Vicarage Road,
    Great Carlton,
    LN11 8JP Louth.
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    EnglandBritish3774370003
    BROWN, Anthony Stuart Edlund
    Pantiles,Chapel Lane
    Swallow
    LN7 6DE Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    Pantiles,Chapel Lane
    Swallow
    LN7 6DE Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish3774360001
    DENISON, Michael John
    29 Station Road
    Grasby
    DN38 6AP Barnetby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    29 Station Road
    Grasby
    DN38 6AP Barnetby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish3774380003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur T.H. BROWN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Martin Glenn Brown
    Business Hive
    13 Dudley Street
    DN31 2AW Grimsby
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    06 avr. 2016
    Business Hive
    13 Dudley Street
    DN31 2AW Grimsby
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Anthony Stuart Edlund Brown
    Business Hive
    13 Dudley Street
    DN31 2AW Grimsby
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    06 avr. 2016
    Business Hive
    13 Dudley Street
    DN31 2AW Grimsby
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    T.H. BROWN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 19 sept. 2014
    Livré le 19 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    'I. All freehold or leasehold property of the company with all present and future buildings, fixtures (trade fixtures) plant and machinery which are on such property. Ii. All patents, patent applications, inventions, trade marks, service marks (whether registered or no), trade names, design rights, registered designs, copyrights, know-how, trade secrets, rights ion computer software and any other intellectual or intangible property rights (including the benefit of any licences or consents.'.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Skipton Business Finance Limited
    Transactions
    • 19 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 04 juin 1997
    Livré le 05 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 acres at east riverside immingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 1996
    Livré le 16 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or norske interiors U.K. limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1995
    Livré le 10 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and norske interiors U.K. limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unis a & b the flarepath elsham wold industrial estate elsham wold with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1995
    Livré le 10 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units b & c south humberside industrial estate grimsby with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1995
    Livré le 10 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at east riverside road immingham grimsby including all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1995
    Livré le 10 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the east of europa way kiln lane industrial ESTAT5E stallingborough grimsby with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 27 avr. 1995
    Livré le 03 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under an invoice discounting agreement between the company and the security holder or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all debts the subject of an invoice discounting arrangement and all other amounts and floating charge such of the moneys the company may receive in respect of the other debts which stand released from the fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 03 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 1994
    Livré le 22 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the north east of europe way stallingborough humberside t/n HS192584.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 1994
    Livré le 04 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 août 1985
    Livré le 27 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 10, elsham wold ind. Estate, elsham, humberside containing land of approx.3 Acres and buildings to be erected thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 oct. 1984
    Livré le 01 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - 3.4 acres of land k/a plot 9, elsham wold industrial estate, brigg south humberside, together with the warehouse & buildings thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1970
    Livré le 18 mars 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on east side of wood lane, great coates, lincs. Title ll 3091 & ll 3092.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1970Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    T.H. BROWN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mars 2020Commencement of winding up
    18 août 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sarah Louise Burge
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    practitioner
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0