INCHCAPE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINCHCAPE PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00609782
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INCHCAPE PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe INCHCAPE PLC ?

    Adresse du siège social
    22a St James's Square
    SW1Y 5LP London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de INCHCAPE PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INCHCAPE PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au21 oct. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au21 oct. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour INCHCAPE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Felipe Aurelio Del Rio Goudie en tant qu'administrateur le 14 mai 2026

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Juan Pablo Del Rio Goudie en tant que directeur le 13 mai 2026

    1 pagesTM01

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    11 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    11 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 02 déc. 2025

    • Capital: GBP 36,165,107.30
    6 pagesSH07

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 19 nov. 2025

    • Capital: GBP 36,302,202.30
    6 pagesSH07

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 04 nov. 2025

    • Capital: GBP 36,395,478.50
    6 pagesSH07

    Nomination de Ms Tracy Jayne Clarke en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 07 oct. 2025

    • Capital: GBP 36,598,994.70
    6 pagesSH07

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 21 oct. 2025

    • Capital: GBP 36,484,849.60
    6 pagesSH07

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 09 sept. 2025

    • Capital: GBP 36,843,822.60
    6 pagesSH07

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 23 sept. 2025

    • Capital: GBP 36,705,212.90
    6 pagesSH07

    Qui sont les dirigeants de INCHCAPE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATERHOUSE, Tamsin
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Secrétaire
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    British171179730001
    BALI, Nayantara
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    SingaporeSingaporean283798590002
    BUHLMANN, Jeremy Martin
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish68106880003
    CLARKE, Tracy Jayne
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish298167570001
    DEL RIO GOUDIE, Felipe Aurelio
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    ChileChilean348558010001
    GROTE, Byron Elmer, Dr
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandAmerican303800240001
    JENSEN, Alexandra Naomi
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish340660830001
    LEWIS, Adrian John
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish309385140001
    PLATT, Elizabeth Alison
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    United KingdomBritish317582300001
    ROWLEY, Stuart John
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    United StatesBritish311356420001
    TAIT, Duncan Andrew
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish159427810004
    CHAPMAN, Penelope Claire
    15 Chimney Court Brewhouse Lane
    E1W 2NU London
    Secrétaire
    15 Chimney Court Brewhouse Lane
    E1W 2NU London
    British121965190001
    WILLIAMS, Roy Charles
    16 Colcokes Road
    SM7 2EW Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    16 Colcokes Road
    SM7 2EW Banstead
    Surrey
    British7221080001
    ALEXANDER, Anthony George Laurence
    Crafnant
    Gregories Farm Lane
    HP9 1HJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Crafnant
    Gregories Farm Lane
    HP9 1HJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British28045050001
    ARMSTRONG OF ILMINSTER, Robert Temple, Lord
    SW1A 0PW London
    House Of Lords
    Administrateur
    SW1A 0PW London
    House Of Lords
    United KingdomBritish50754640001
    ARNOLD, Simon Rory
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    British66604710003
    BARING, Peter
    29 Ladbroke Square
    W11 3NB London
    Administrateur
    29 Ladbroke Square
    W11 3NB London
    British2842410003
    BAXENDELL, Peter Brian, Sir
    10 Upper Cheyne Row
    SW3 5JN London
    Administrateur
    10 Upper Cheyne Row
    SW3 5JN London
    British9037770001
    BINDRA, Kanwarpal Singh
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    SingaporeAmerican161729080001
    BOMHARD, Stefan Andreas
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandGerman196391190002
    BORROWS, Simon Alexander
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    United KingdomBritish43809980003
    CHENG, Paul Ming Fun
    1202 Tavistock
    10 Tregunter Path
    FOREIGN Hong Kong
    Administrateur
    1202 Tavistock
    10 Tregunter Path
    FOREIGN Hong Kong
    American32604140002
    CHIEN, Raymond Kuo Fung, Doctor
    11a Braga Circuit
    Kowloon
    FOREIGN Hong Kong
    Administrateur
    11a Braga Circuit
    Kowloon
    FOREIGN Hong Kong
    Chinese H.K53832720002
    COOPER, Alison Jane
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish73712680003
    CULLEN, Leslie Gray
    32 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    32 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish15782290001
    CUMMINS, Andrew Douglas
    4 Argyll Road
    W8 7DB London
    Administrateur
    4 Argyll Road
    W8 7DB London
    Australian1803330001
    CUSHING, Philip Edward
    7 Hogarth Court
    North End
    NW3 7HJ London
    Administrateur
    7 Hogarth Court
    North End
    NW3 7HJ London
    British69325760002
    DE ZOETEN, Gijsbert
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandDutch262045360002
    DEL RIO GOUDIE, Juan Pablo
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    ChileChilean304179230001
    EGAN, John Leopold, Sir
    4 Mill Street
    CV34 4HB Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    4 Mill Street
    CV34 4HB Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish59710260001
    EMPEY, Rachel Clare
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    GermanyBritish211281610001
    FERGUSON, Alan Murray
    111 Grange Road
    Ealing
    W5 3PH London
    Administrateur
    111 Grange Road
    Ealing
    W5 3PH London
    British24795610003
    GUERRA, Karen
    Residence Rambert
    26-29 Avenue Eugene Rambert
    Clarens/Montreaux
    Apartment 1
    1815 Ch
    Switzerland
    Administrateur
    Residence Rambert
    26-29 Avenue Eugene Rambert
    Clarens/Montreaux
    Apartment 1
    1815 Ch
    Switzerland
    British110139870003
    HANNA, Kenneth George
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    EnglandBritish78515410005
    HEATH, Reginald Frank
    Linden Croft
    Linden Road St Georges Hill
    KT13 0QW Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Linden Croft
    Linden Road St Georges Hill
    KT13 0QW Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish30254400001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0