BML REALISATIONS 2016 LIMITED

BML REALISATIONS 2016 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBML REALISATIONS 2016 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00625299
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BML REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    • Élevage de volailles (01470) / Agriculture, sylviculture et pêche
    • Production de produits à base de viande et de viande de volaille (10130) / Industries manufacturières
    • Fabrication d'aliments préparés pour animaux de ferme (10910) / Industries manufacturières

    Où se situe BML REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Smith & Williamson Llp
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BML REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERNARD MATTHEWS LIMITED02 avr. 200102 avr. 2001
    BERNARD MATTHEWS TRADING LIMITED22 févr. 200122 févr. 2001
    BERNARD MATTHEWS P.L.C.08 avr. 195908 avr. 1959

    Quels sont les derniers comptes de BML REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BML REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    25 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    22 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    19 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    20 pagesWU07

    Nomination d'un liquidateur

    3 pagesWU04

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    4 pagesCOCOMP

    Changement d'adresse du siège social de Four Brindleyplace Birmingham West Midlands B1 2HZ à C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY le 23 oct. 2017

    2 pagesAD01

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    26 pagesAM25

    Cessation de la nomination de Zaliha Williamson en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Burnett en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 mars 2017

    20 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    17 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    43 pagesF2.18

    Changement d'adresse du siège social de Great Witchingham Hall Great Witchingham Norwich Norfolk NR9 5QD à Four Brindleyplace Birmingham West Midlands B1 2HZ le 25 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    44 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que secrétaire le 18 août 2016

    1 pagesTM02

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mai 2016

    État du capital au 27 mai 2016

    • Capital: GBP 31,529,433.5
    SH01

    Cessation de la nomination de David John Joll en tant que directeur le 06 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan Rae Dalziel Jamieson en tant qu'administrateur le 29 mars 2016

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 28 juin 2015

    38 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BML REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMIESON, Alan Rae Dalziel
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    C/O Smith & Williamson Llp
    Administrateur
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    C/O Smith & Williamson Llp
    United KingdomBritishCompany Director31138330004
    BROWN, John Granger
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    British11486660001
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    170466360001
    REGER, David Michael
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    British151343430001
    BARTRAM, Noel Frederick
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishOperations Director37442010003
    BROWN, John Granger
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCorporate Director & Secretary11486660001
    BURNETT, Robert
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    Administrateur
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    ScotlandBritishGroup Ceo86190250002
    DALLA MURA, Bart Wallace
    Epwell Grounds
    OX15 6HF Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Epwell Grounds
    OX15 6HF Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomAmerican,BritishDirector113217530001
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector170465830001
    HARRISON, Neil Charles
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector111081410001
    HAYES, George Leslie John
    Fakenham Road
    Beetley
    NR20 4BT Dereham
    39
    Norfolk
    Administrateur
    Fakenham Road
    Beetley
    NR20 4BT Dereham
    39
    Norfolk
    EnglandBritishEuorpean Marketing Director81432860001
    JOLL, David John
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector178372710001
    JOLL, David John
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    Administrateur
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    United KingdomBritishManaging Director178372710001
    MATTHEWS, Bernard Trevor
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishChairman10918210001
    MCCALL, David Slesser
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector60326440001
    MCCALL, David Slesser
    Woodland Hall
    Redenhall
    IP20 9QW Harleston
    Norfolk
    Administrateur
    Woodland Hall
    Redenhall
    IP20 9QW Harleston
    Norfolk
    United KingdomBritishTelevision Executive60326440001
    MCFARQUHAR, Archibald Mcalister
    21 Stuart Gardens
    St Faiths Lane
    NR1 1JG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    21 Stuart Gardens
    St Faiths Lane
    NR1 1JG Norwich
    Norfolk
    BritishPlanning & Nutrition Director11634450001
    MEARS, Robert Michael
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector136995510002
    NEWTON, David Alexander
    Falcon House
    Mellis
    IP23 8DQ Eye
    Suffolk
    Administrateur
    Falcon House
    Mellis
    IP23 8DQ Eye
    Suffolk
    BritishCompany Director108260001
    SIMPSON, Andrew John
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    England
    Administrateur
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    England
    EnglandBritishDirector105165150001
    SIMPSON, Christopher John Harry
    Pineapple Farm Station Road
    Great Fransham
    Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    Pineapple Farm Station Road
    Great Fransham
    Dereham
    Norfolk
    BritishNon Executive Director10918200002
    WILLIAMSON, Zaliha
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    Administrateur
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    West Midlands
    EnglandBritishDirector323983980001

    BML REALISATIONS 2016 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 août 2015
    Livré le 02 sept. 2015
    En cours
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of bernard matthews limited including without limitation a first legal mortgage and fixed charge over (1) the freehold land known as massingham, roockery farm, rudham road little massingham, nr kings lynn registered at the land registry under title number NK292742 and (2) the freehold land known as meadowsweet, upper holton, halesworth, IP19 8NL registered at the land registry under title number SK66009 and a first fixed charge over the patents and trademarks as more particularly described in schedule 6 of the debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 02 sept. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2013
    Livré le 05 sept. 2013
    En cours
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of bernard matthews limited, including fixed charges over the intellectual property detailed in schedule 6 of the debenture and fixed charges over the properties owned by bernard matthews limited listed in schedule 4 of the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 05 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of amendment and accession
    Créé le 20 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2008
    Livré le 14 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any of the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustee of the Bernard Matthews Pension Fund
    Transactions
    • 14 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of debenture
    Créé le 11 juin 2007
    Livré le 21 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 21 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 15 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • De Lage Landen Ireland Company
    Transactions
    • 15 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h properties being great witchingham plant (south site) great witchinghamnorwich norfolk, north site 1 great witchingham norwich norfolk, north site 2 great witchingham norwich norfolk, for details of further properties charged, plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 05 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to any finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The Agent)
    Transactions
    • 05 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BML REALISATIONS 2016 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2016Administration started
    19 sept. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul James Meadows
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    practitioner
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    2
    DateType
    30 juil. 2021Conclusion of winding up
    14 sept. 2017Petition date
    19 sept. 2017Commencement of winding up
    07 janv. 2022Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Adam Henry Stephens
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Finbarr O'Connell
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0