KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED

KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00627338
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    • Commerce de gros de pièces et accessoires pour véhicules automobiles (45310) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O INTERPATH ADVISORY
    2nd Floor 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KING'S ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED04 mai 195904 mai 1959

    Quels sont les derniers comptes de KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le29 mars 2019
    Date d'échéance des prochains comptes29 déc. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 nov. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 nov. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 nov. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2024

    23 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2023

    23 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2022

    25 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH à 2nd Floor 45 Church Street Birmingham B3 2RT le 14 janv. 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juin 2021

    26 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    42 pages600

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:LIQ06 = Resignation date of Mark Jeremy Orton was 15/06/2021.
    3 pagesLIQ MISC

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    27 pagesAM22

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    26 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    37 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    55 pagesAM03

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    18 pagesAM02

    Changement d'adresse du siège social de 22 York Buildings London WC2N 6JU England à One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH le 17 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    33 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 mars 2018 au 29 mars 2018

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2018 au 30 mars 2018

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David Ian Thorley en tant que secrétaire le 30 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Ian Thorley en tant que directeur le 30 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BADER, Adrian Stuart
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    2nd Floor
    Administrateur
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    2nd Floor
    United KingdomBritishDirector165433830002
    BADER, Adrian Stuart
    Buckerell
    EX14 3EP Honiton
    Knabben
    Devon
    England
    Secrétaire
    Buckerell
    EX14 3EP Honiton
    Knabben
    Devon
    England
    179271660001
    LISTER, Simon John
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    Secrétaire
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    British14923430002
    THORLEY, David Ian
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    Secrétaire
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    192809450002
    COOPER, Mark Jonathon
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    22
    England
    Administrateur
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    22
    England
    United KingdomBritishDirector22455280002
    FOGARTY, Edmond Michael
    33 Graemesdyke Avenue
    SW14 7BH London
    Administrateur
    33 Graemesdyke Avenue
    SW14 7BH London
    United KingdomBritishGeneral Manager127128990001
    GASTER, Peter
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    Administrateur
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director22417800004
    LEDERHOSE, John George
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    Administrateur
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director8759730002
    LIDDLE, Brian Lawson
    Roecliffe Peth Lane
    NE40 3PB Ryton
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Roecliffe Peth Lane
    NE40 3PB Ryton
    Tyne & Wear
    BritishGeneral Manager22455250001
    LISTER, Simon John
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    Administrateur
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    United KingdomBritishCompany Secretary14923430002
    RUSHTON, Edeltraut Wilhelmina
    32 Lower Boston Road
    Hanwell
    W7 2NR London
    Administrateur
    32 Lower Boston Road
    Hanwell
    W7 2NR London
    AustrianCompany Director22174550001
    RUSHTON, Philip Benjamin Dick
    32 Lower Boston Road
    Hanwell
    W7 2NR London
    Administrateur
    32 Lower Boston Road
    Hanwell
    W7 2NR London
    BritishCompany Director22174540001
    SEAL, James Anthony
    17a Park Road
    TW10 6NS Richmond
    Surrey
    Administrateur
    17a Park Road
    TW10 6NS Richmond
    Surrey
    BritishExport Director104739130001
    THOMAS, Ian Jeffrey
    Pump Lane
    UB3 3NB Hayes
    Unit 4 Chailey Industrial Estate
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Pump Lane
    UB3 3NB Hayes
    Unit 4 Chailey Industrial Estate
    Middlesex
    United Kingdom
    LuxembourgBritishCeo (Director)184666330001
    THORLEY, David Ian
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    22
    England
    Administrateur
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    22
    England
    United KingdomBritishFinancial Director97880070001
    WILSON, Peter Rowland
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    Administrateur
    Unit 4
    Chailey Industrial Estate
    UB3 3NB Pump Lane
    Hayes Middlesex
    United KingdomBritishDirector56493830001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Fourth Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WL Burton-On-Trent
    Unit 1
    England
    01 juil. 2016
    Fourth Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WL Burton-On-Trent
    Unit 1
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01359123
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 juin 2018
    Livré le 05 juin 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited
    Transactions
    • 05 juin 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 17 nov. 2017
    Livré le 24 nov. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Resolve Invest Limited
    Transactions
    • 24 nov. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 janv. 2018Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 09 janv. 2014
    Livré le 27 janv. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 janv. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 janv. 2018Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 13 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 déc. 2012
    Livré le 28 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 28 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 janv. 2018Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 13 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 13 juin 2012
    Livré le 29 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Lederhose and Peter Gaster
    Transactions
    • 29 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 08 sept. 2011
    Livré le 09 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All amounts now and in the future credited to account number 15204170 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 07 sept. 2011
    Livré le 13 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 13 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 19 mai 2006
    Livré le 02 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance LTD
    Transactions
    • 02 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 14 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as unit 7 and 9 first avenue drum industrial estate birtley newcastle; t/no NZ2653B. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 12 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 09 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 343 hatton road bedfont middlesex-MX47411. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 09 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 1, 2, 3, and 4 & land adjoining kingsbury road southampton hampshire-HP553372 & HP544792. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 09 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 63 station road ilminster somerset-ST118168. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 09 mars 1998
    Livré le 10 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 1,2, 3 and 4 kingsbury road southampton hampshire t/no;-HP544792 together with goodwill amd proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 mai 1995
    Livré le 17 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    63 station road, ilminster, somerset. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1989
    Livré le 08 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25 mornington road smethwick W. midlands.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 août 1988
    Livré le 22 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Peter Gaster,
    • Philip Benjamin Dick Rushton
    • John George Lederhose
    • Edeltraut Wilhelmena Rushton.
    • Maurice Dyson
    Transactions
    • 22 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 juin 1991Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juil. 1988
    Livré le 29 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 7/9 drum indust est. Birtley, durham.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1987
    Livré le 30 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H units 1 & 2 145 & 147 boston road, hanwell, london W7.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 11 juin 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 27 mai 1986
    Livré le 06 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from gcr haulage co limited and/or thames haulage. (Holdings) limited and/or king road tyres. (International) limited and/or thames haulage limited and/or w w transport co limited and/or the p & t haulage service limited and/or thames haulage international limited to the chargee on any any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific mortgage
    Créé le 04 févr. 1980
    Livré le 22 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40000 due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    All those vehicles listed in column 3 of doc M57.
    Personnes ayant droit
    • Industrial Bank of Scotland Limited
    Transactions
    • 22 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    First legal charge
    Créé le 28 mars 1979
    Livré le 04 avr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    343 hatton rd. Hounslow middlesex title no mx 47411.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 04 avr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 oct. 1972
    Livré le 31 oct. 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital & all fixtures, plant and machinery (see doc. 33).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 oct. 1972Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    KINGS ROAD TYRES AND REPAIRS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 juin 2019Administration started
    03 juin 2020Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Robert Pole
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    2
    DateType
    03 juin 2020Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Robert Pole
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Christopher Robert Pole
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Howard Smith
    Interpath Advisory, 1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    practitioner
    Interpath Advisory, 1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0