TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED

TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00631192
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED ?

    • (5113) /

    Où se situe TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 sept. 2011

    LRESSP

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG le 06 oct. 2011

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2010

    État du capital au 11 nov. 2010

    • Capital: GBP 10,314
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Résolutions

    Resolutions
    0 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    TANN, Lynda Anne
    88 Deacons Hill Road
    WD6 3JQ Elstree
    Hertfordshire
    Secrétaire
    88 Deacons Hill Road
    WD6 3JQ Elstree
    Hertfordshire
    British16961380002
    TANN, Lynda Anne
    88 Deacons Hill Road
    WD6 3JQ Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    88 Deacons Hill Road
    WD6 3JQ Elstree
    Hertfordshire
    British16961380002
    TANN, Richard
    88 Deacons Hill Road
    WD6 3JQ Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    88 Deacons Hill Road
    WD6 3JQ Elstree
    Hertfordshire
    British16961390002

    TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 23 juin 1995
    Livré le 28 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-24-42 palmerston road wealdstone middlesex t/n-NGL693326 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 1995
    Livré le 28 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-44-50 palmerston road wealdstone middlesex. And assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 1992
    Livré le 16 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £356,000
    Brèves mentions
    24/42 palmerston rd. Wealdstone harrow middx.t/n ngl 693326.floating charge on. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Union Life Assurance Company Limited
    Transactions
    • 16 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/as 24-42 palmerston road, wealdstone,middlesex,together with buildings and fixtures see doc for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of building agreement.
    Créé le 24 avr. 1991
    Livré le 29 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's interest under a building agreement dated 23.1.91 and made between the mayor and burgesses of the b of harrow and the council, land k/a 24-42 palmerston road and the premises and buildings thereon (see 395/m/85/c 29/4 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 29 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 avr. 1991
    Livré le 29 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 29 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 avr. 1991
    Livré le 29 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property k/a 27-35 masons avenue 31 palmerston road wealdstone road wealdstone middlesex, and 25, 27 and 29 palmerston road wealdstone t/no:- mx 139399 with all buildings and fixtures fixed plant and machinery (please see doc 395/m/86/c/29 4 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 29 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 juil. 1985
    Livré le 04 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold premises 25 27 and 29 palmerston road, wealdstone harrow middlesex title no. Mx 139399.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 26 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TANN & SONS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 sept. 2011Commencement of winding up
    01 août 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alistair Steven Wood
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    practitioner
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0