BROADY VALVES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROADY VALVES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00631683
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROADY VALVES LIMITED ?

    • (2875) /

    Où se situe BROADY VALVES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROADY VALVES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WILLIAM BROADY & SON LIMITED01 juil. 195901 juil. 1959

    Quels sont les derniers comptes de BROADY VALVES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2010
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BROADY VALVES LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 avr. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BROADY VALVES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BROADY VALVES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 11 janv. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    5 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination de Salvatore Ruggeri en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Massimiliano Ruggeri en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Anthony Wenman Ellis en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Derrick en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Porter en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2011 au 31 déc. 2010

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2007

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de BROADY VALVES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DERRICK, Paul Anthony
    46 Hartsholme Park
    Kingswood
    HU7 3HP Hull
    Secrétaire
    46 Hartsholme Park
    Kingswood
    HU7 3HP Hull
    British64853560002
    ELLIS, Anthony Wenman
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    Administrateur
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    ItalyBritish152784410001
    RUGGERI, Massimiliano
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    Administrateur
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    ItalyItalian152784730001
    RUGGERI, Salvatore
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    Administrateur
    English Street
    Hull
    HU3 2DU East Yorkshire
    ItalyItalian152784940001
    WALKER, James
    Ladycort Newclose Lane
    DN14 6LT Goole
    Secrétaire
    Ladycort Newclose Lane
    DN14 6LT Goole
    British7381990001
    DERRICK, Anthony John
    Poplar House Farm Church Lane
    Skirlaugh
    HU11 5EU Hull
    East Yorkshire
    Administrateur
    Poplar House Farm Church Lane
    Skirlaugh
    HU11 5EU Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish7382000001
    GRIFFITHS, John Peter
    27 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    27 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    British7382010001
    MURR, Derek
    Langley Farm Parkside
    BD16 4AD Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Langley Farm Parkside
    BD16 4AD Bingley
    West Yorkshire
    British38282220002
    PORTER, Michael
    51 The Ridings
    HU5 5HW Hull
    East Yorkshire
    Administrateur
    51 The Ridings
    HU5 5HW Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish64853620001
    ROBINSON, Frank
    717 Anlaby Road
    HU4 6BX Hull
    Administrateur
    717 Anlaby Road
    HU4 6BX Hull
    British64853690001
    ROBINSON, Frank
    717 Anlaby Road
    HU4 6BX Hull
    Administrateur
    717 Anlaby Road
    HU4 6BX Hull
    British64853690001
    STEPHENSON, Robin
    43 Magdalen Lane
    Hedon
    HU12 8LA Hull
    East Yorkshire
    Administrateur
    43 Magdalen Lane
    Hedon
    HU12 8LA Hull
    East Yorkshire
    British64853730001
    WALKER, James
    Ladycort Newclose Lane
    DN14 6LT Goole
    Administrateur
    Ladycort Newclose Lane
    DN14 6LT Goole
    British7381990001

    BROADY VALVES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 27 juil. 2000
    Livré le 29 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at english street kingston upon hull. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 juin 1999
    Livré le 07 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Créé le 14 oct. 1991
    Livré le 18 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £31138-00 being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement.
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance see 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 18 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 22 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1984
    Livré le 01 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate on the south side of english street and west side of st james street, kingston upon hull.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 1982
    Livré le 29 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land 1690 sq yds south of st james square st. James street kingston-upon-hull.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 1982
    Livré le 29 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on nw corner of junction of english street & st james street kingston-opon-hull.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 1982
    Livré le 29 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land south of english street & west of st james street hull.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 1982
    Livré le 29 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    138 sq yds f/h land south of 97 english street hull.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 1982
    Livré le 29 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & buildings on n e corner of the junction of english street & st james street hull.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 12 oct. 1981
    Livré le 15 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts & other debts now & from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 16 juin 1972
    Livré le 23 juin 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plots land 2 of morton grove industrial estate at morton, nr malton, east yorkshire together with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1972Enregistrement d'une charge
    • 16 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0