LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED

LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00632465
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Matthew James Torode en tant que directeur le 23 août 2019

    1 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET England à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS le 30 août 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 août 2018

    LRESSP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman le 31 janv. 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Matthew James Torode en tant qu'administrateur le 16 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Leonard Grose en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Hermes Secretariat Limited en tant que secrétaire le 31 janv. 2018

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Mepc Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 janv. 2018

    1 pagesTM02

    Modification des détails de Mepc (1946) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2018

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ à Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET le 31 janv. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Emily Ann Mousley en tant que directeur le 30 juin 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman en tant qu'administrateur le 23 juin 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2016

    État du capital au 11 janv. 2016

    • Capital: GBP 350,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 déc. 2014

    État du capital au 30 déc. 2014

    • Capital: GBP 350,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Leonard Grose le 29 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HERMES SECRETARIAT LIMITED
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Secrétaire
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03717842
    93700910001
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    Administrateur
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003
    CAINES, Geoffrey Harold
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    Secrétaire
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    British22701030002
    PRICE, John Dewi Brychan
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    Secrétaire
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    British3041640002
    MEPC SECRETARIES LIMITED
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    4th Floor
    Secrétaire
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    4th Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4290683
    79708020003
    BARWICK, Charles Julian
    8 Belgrave Road
    SW13 9NS London
    Administrateur
    8 Belgrave Road
    SW13 9NS London
    EnglandBritishChartered Surveyor3818640001
    BATEMAN, John Anthony
    Hurst House
    Lincombe Lane Boars Hill
    OX1 5DZ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Hurst House
    Lincombe Lane Boars Hill
    OX1 5DZ Oxford
    Oxfordshire
    BritishChartered Surveyor69753820002
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector Taxation100504300001
    CAINES, Geoffrey Harold
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    Administrateur
    Bindon 48 Hartley Old Road
    CR8 4HG Purley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant22701030002
    COURTAULD, Toby Augustine
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    Administrateur
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    BritishChartered Surveyor46882260003
    DIBLEY, Hugh Leslie Stewart
    Morrisdown
    Piltdown
    TN22 3XU Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Morrisdown
    Piltdown
    TN22 3XU Uckfield
    East Sussex
    BritishChartered Surveyor2012160001
    DUNN, Peter Harold
    10 High Street
    TW12 2SJ Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    10 High Street
    TW12 2SJ Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritishRetired629830001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Administrateur
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant108586450001
    EXLEY, Richard John
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Clematis Cottage Turners Green Lane
    TN5 6TS Wadhurst
    East Sussex
    BritishChartered Surveyor50191130002
    GROSE, David Leonard
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishAccountant120479020004
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Surveyor33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    38 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    38 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant93017010003
    MCGARRITY, Stewart
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant65801380001
    MONIZ, Christopher Mario
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritishCertified Accountant3831690001
    MOUSLEY, Emily Ann
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    Administrateur
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    EnglandBritishChartered Accountant155262770003
    PERRY, Albert Richard
    Gatcombe Chase Arrowsmith Road
    Canford Magna
    BH21 3BD Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    Gatcombe Chase Arrowsmith Road
    Canford Magna
    BH21 3BD Wimborne
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director2012170001
    PIERCE, Graham Charles
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    Administrateur
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    United KingdomUkAccountant123665160001
    STRATTON, Carol Ann
    127 Maidstone Road
    Ruxley Corner Foots Cray
    DA14 5HX Sidcup
    Kent
    Administrateur
    127 Maidstone Road
    Ruxley Corner Foots Cray
    DA14 5HX Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCompany Secretary79680570001
    THOMPSON, Nathan James
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    Administrateur
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    BritishChartered Surveyor43320980004
    TORODE, Matthew James
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    Administrateur
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020 Eskdale Road
    United KingdomBritishAccountant196412900002
    TUCKER, Louis Newton
    Bearehurst
    Holmwood
    RH5 4LR Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Bearehurst
    Holmwood
    RH5 4LR Dorking
    Surrey
    BritishSolicitor37042480001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Administrateur
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant4779170003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mepc (1946) Limited
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    06 avr. 2016
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement00420575
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second supplemental trust deed
    Créé le 13 oct. 2000
    Livré le 16 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee £30, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 14 september 1982 and £70, 000, 000 interest and all other monies intended to be secured by a supplemental trust deed dated 12 january 1984
    Brèves mentions
    F/H property at chineham business park chineham basingstoke hampshire t/n HP316566 HP397816 HP317682 HP173001 HP498388 HP423354 HP317683 NGL278770 with all buildings fixtures and benefit of all agreements under the trust deed.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transactions
    • 16 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1997
    Livré le 02 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Friarsgate monks path solihull west midlands t/n wm 622993.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of confirmation
    Créé le 25 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Brèves mentions
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a land and buildings on the south side of pen-y-ball street holywell t/n WA350272. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of confirmation
    Créé le 25 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Brèves mentions
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a the f/h land and buildings on the south side of wheelock street middlewich t/n CH287780. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of confirmation
    Créé le 25 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 15 july 1992 as supplemented by a deed of novation dated 14 june 1993 as further supplemented by a deed of even date herewith
    Brèves mentions
    By way of confirmation and restatement the charges and assignments set forth in clauses 2(1) and 2(3) of a legal charge dated 15 july 1992 over the f/h land and property k/a land and buildings on the south side of new road willenhall t/n WN423682. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 août 1995
    Livré le 14 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal interest and all other monies due or to become due from psit PLC and/or louisville investments limited to the chargee under the terms of the legal charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit J1 tyne tunnel trading estate tyne and wear north tyneside.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal
    Transactions
    • 14 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party legal charge
    Créé le 07 août 1995
    Livré le 24 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from psit PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit S3 tyne tunnel trading estate north tyneside tyne & wear t/no.TY106207 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 30 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Houndmills industrial estate, basingstoke, hampshire t/no HP491798.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 nov. 1992
    Livré le 20 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to beome due from property security investment trust PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units D1 and D3 hanover business park altrincham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date
    Brèves mentions
    F/H land and buildings to the south of wheelock street, middlewich t/no: ch 287780 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south side of new road, willenhall t/no: WM423682(see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee of even date
    Brèves mentions
    F/H land and buildings at pen-y-ball street, hollywell, clwyd t/no: wa 350272 (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1988
    Livré le 26 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from property securiey investments trust PLC under the terms of the facility agreements dated 18TH august 1983 and the charge to the charger
    Brèves mentions
    F/Hold piece or parcel of land situate in warwickshire in the district of rugby being land & buildings on the east and west side of consul rd t/n wk 234723 together with the terms covenants etc of the schedule of leases annexed see doc M15 for fuller details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal
    Transactions
    • 26 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First legal charge
    Créé le 11 janv. 1988
    Livré le 25 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Brèves mentions
    All that part of the land and buildings lying to the south of wheelock st.middlewich t/n ch 271714. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • First Interstate Bank of California
    Transactions
    • 25 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First legal charge
    Créé le 11 janv. 1988
    Livré le 25 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as land & buildings on the south side of pen-y-bal street, holywell t/n wa 350272 see doc M3 for fuller details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • First Interstate Bank of California
    Transactions
    • 25 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First legal charge
    Créé le 11 janv. 1988
    Livré le 25 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 18TH june 1985
    Brèves mentions
    Part of the land & buildings on the south side of new rd willenhall t/n wa 387476 see doc M2 for fuller details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • First Interstate Bank of California
    Transactions
    • 25 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juin 1986
    Livré le 20 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises at crockford lane basingstoke, hants. See doc M145 (now or shortly to be known as clyneham business park, crockford lane (aforesaid).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 1986Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on the 29TH may 1986.
    Créé le 29 mai 1986
    Livré le 06 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneis due or to become due from property security investment trust PLC to the chargee.
    Brèves mentions
    The buildings comprising supermarket premises known as 140/142 arbroath road, dundee, angus & tayside region with grounds & rights pertaining thereto.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over securities
    Créé le 18 juin 1985
    Livré le 28 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee dated 18/6/85 or any agreement relating thereto and the charge
    Brèves mentions
    £1,000,000 by nominal amount of treasury 9% stock 1992/96 and all dividends or interest (full details see doc M143).
    Personnes ayant droit
    • First Interstate Bank of California
    Transactions
    • 28 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juin 1985
    Livré le 07 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings known as units B1,B3 C8, D1, D2, D3, D4 & D6 situate at M62 trading estate rawcliffe road goole together with all buildings and any thereon and developments now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Grindlays Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 1985
    Livré le 25 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & buildings lying to the west of springhead road, northfleet being within the north west kent enterprise zone no.1, Springhead enterprise park, springhead road, northfleet kent t/n k 568656 together with all buildings and and any thereon developments now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Grindlays Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 déc. 1984
    Livré le 14 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate to the s w of holt way, holt park adel leeds 16 together with the supermarket 16 shop units and office premises erected thereon or on some part thereof all of which is known as holt park centre, add t/ns wyk 184409 &wyk 199914.
    Personnes ayant droit
    • Grindlays Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorondum & deposit of deeds and documents
    Créé le 26 janv. 1984
    Livré le 30 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the property security investment trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H land at hyde green pucklechurch margotsfield in the county of gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 sept. 1983
    Livré le 27 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 8/aug/83
    Brèves mentions
    £750,000 of 10 1/2% treasury stock 1999 together with all income interest & dividends paid or payable after the date hereof on any of the above & all stocks shares securities rights money or property (see doc M137 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal
    Transactions
    • 27 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 août 1983
    Livré le 24 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from property security investment trust PLC under the terms of a loan agreement dated 18/8/83 to the chargee
    Brèves mentions
    F/H phase iii of the milton keynes development corporations bradwell abbey employment area milton keynes buckinghamshire. (Approx 2.76 acres).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal
    Transactions
    • 24 août 1983Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LOUISVILLE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 août 2018Commencement of winding up
    01 nov. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0