NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00634498
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A6AY8Y28

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01
    X5KWM4W8

    Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    1 pagesTM02
    X5KRAXQE

    Nomination de British Land Company Secretarial Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    2 pagesAP04
    X5KRADDN

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA
    L5F1B8BV

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5EXIWIX

    Nomination de Mr Charles John Middleton en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01
    X5CJBJUX

    Nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01
    X5BNY2NU

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA
    A4HY9GV5

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2015

    État du capital au 29 juil. 2015

    • Capital: GBP 500
    SH01
    X4COY4Z4

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Lucinda Margaret Bell le 09 oct. 2014

    2 pagesCH01
    X3J6GE0B

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2013

    16 pagesAA
    A3IOBPAX

    legacy

    184 pagesPARENT_ACC
    A3HJQDDN

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2
    A3HJQDFF

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2
    A3HJ8ZY0

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2014

    État du capital au 14 juil. 2014

    • Capital: GBP 500
    SH01
    X3C3VU6W

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA
    A2HPN2S0

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 30 juil. 2013

    SH01
    X2DPB4VE

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Philip John Martin le 30 juil. 2013

    1 pagesCH03
    X2DPB4UY

    Modification des coordonnées de l'administrateur Lucinda Margaret Bell le 30 juil. 2013

    2 pagesCH01
    X2DPB4V6

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    3 pagesAA
    A1IF8ATF

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    X1DBAXC8

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA
    A5PA5XXD

    Qui sont les dirigeants de NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Secrétaire
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    WILSON, Michael Anthony
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    Secrétaire
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    British68971270001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Administrateur
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritishCompany Director40766290003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLUTTON, Rodney
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    Administrateur
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    BritishDirector4388360001
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishChartered Surveyor73961570001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Administrateur
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    BritishChartered Accountant109383240001
    NETTLETON, John Dering
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    Administrateur
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    EnglandEnglishDirector1866530002
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritishChartered Accountant14448630001
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSurveyor106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Administrateur
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director73972350001
    WATES, Paul Christopher Ronald
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    EnglandBritishDirector2119440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wates City Of London Properties Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 avr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom Companies Registry
    Numéro d'enregistrement1788526
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage of shares
    Créé le 23 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to deutsche pfandbrief- und hypothekenbank aktiengesellschaft (the "agent") and the finance parties (as defined) or any of them under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The issued share capital in qsl and all interest in the shares and related rights see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Un Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of shares
    Créé le 19 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee under each of the finance documents (as therein defined) to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening S151 of the companies act 1 985
    Brèves mentions
    All shares: the issued share capital of number 90 queen street limited and all dividends thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 avr. 1996
    Livré le 07 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents to which the obligor is a party except for any obligation which,if it were so included, would result in the chargor debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transactions
    • 07 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of shares
    Créé le 18 avr. 1996
    Livré le 07 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in this charge contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    All shares held by the chargor and/or any nominee in its behalf and all related rights and first fixed charge the chargor's interest in all the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transactions
    • 07 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and each other finance party under the terms of each of the finance documents (as defined) to which such obligor is a party
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0