LEAFIELD ENGINEERING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LEAFIELD ENGINEERING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00634776 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LEAFIELD ENGINEERING LIMITED ?
Adresse du siège social | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LEAFIELD ENGINEERING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour LEAFIELD ENGINEERING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 09 avr. 2019
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Gregory Lewis en tant qu'administrateur le 19 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 03 janv. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Bowers en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Sarah Louise Ellard en tant qu'administrateur le 31 août 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael James Flowers le 13 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Michael James Flowers en tant qu'administrateur le 24 juil. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LEAFIELD ENGINEERING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLARD, Sarah Louise | Secrétaire | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
ELLARD, Sarah Louise | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | England | British | Group Legal Director | 43855640013 | ||||
LEWIS, Andrew Gregory | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 222848510001 | ||||
CHAPPLE, Timothy Jonathan | Secrétaire | 18 Roger Beck Way Sketty SA2 0JF Swansea | British | Financial Director | 28933940002 | |||||
EDWARDS, David Stephen | Secrétaire | 92 St Austell Way Penzance Drive SN2 2DG Swindon Wiltshire | British | 64259030002 | ||||||
FORSYTH, Nigel John | Secrétaire | Park Farm Barn PO7 4SB Hambledon Hampshire | British | Company Director | 59380470002 | |||||
WHADCOCK, Stephen Arthur | Secrétaire | 75 Nursteed Road SN10 3AJ Devizes Wiltshire | British | 6425330001 | ||||||
BLOTT, James | Administrateur | The Rest West Street PO7 4RW Hambledon Hampshire | British | Company Director | 59380580002 | |||||
BOWERS, Steven John | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 176189250001 | ||||
CARPENTER, Cecil John | Administrateur | Zion Hill Cottage Clapton BA3 4DZ Bath | England | British | Business Development Director | 98361540001 | ||||
CHAPPLE, Timothy Jonathan | Administrateur | 18 Roger Beck Way Sketty SA2 0JF Swansea | British | Financial Director | 28933940002 | |||||
DYKE, Robert Alexander | Administrateur | Grove Farm 156 Winsley Road BA15 1PA Bradford On Avon Wiltshire | England | British | Company Director | 51678350002 | ||||
EDWARDS, David Stephen | Administrateur | 92 St Austell Way Penzance Drive SN2 2DG Swindon Wiltshire | British | Finance Director | 64259030002 | |||||
FLOWERS, Michael James | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 188873370002 | ||||
FORSYTH, Nigel John | Administrateur | Park Farm Barn PO7 4SB Hambledon Hampshire | British | Company Director | 59380470002 | |||||
HAMILTON, Archibald Gavin, The Right Honourable Sir | Administrateur | Snowdenham House Snowdenham Lane Bramley GU5 0DB Guildford Surrey | British | Non Executive Dir | 36648100001 | |||||
HAMILTON OF EPSOM, Archibald Gavin, Lord | Administrateur | 14 Tufton Court Tufton Street Tufton SW1P 3QH London | England | British | Company Director | 112172480001 | ||||
HELME, Michael John | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | England | British | Professional Engineer | 91910030002 | ||||
JACOMB, Kenneth Edward | Administrateur | Holly Tree Farm Sandy Lane SN12 2QB Chippenham Wiltshire | British | Engineering And Marketing Director | 6425340001 | |||||
MEREDITH, Brian Horace | Administrateur | 20a The Street Broughton Gifford SN12 8PW Melksham Wiltshire | British | Engineering Director | 26601600001 | |||||
MUNRO, Peter Austin Dods | Administrateur | The Wing Selwood Lodge Leys Lane BA11 2JX Frome Somerset | British | Manufacturing Director | 67696410002 | |||||
PAPWORTH, Mark Harry | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 103085690002 | ||||
PRICE, David John | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 75259760004 | ||||
RAYNER, Paul Adrian | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
TONGE, Richard Leslie | Administrateur | 4 Trimnells Colerne SN14 8EP Chippenham Wiltshire | British | Managing Director | 6425360001 | |||||
WHADCOCK, Stephen Arthur | Administrateur | 75 Nursteed Road SN10 3AJ Devizes Wiltshire | British | Finance Director | 6425330001 | |||||
WOODS, Stephen William | Administrateur | 1 Silver Street Gastard SN13 9PY Corsham Wiltshire | England | British | Operations Director | 64258950002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LEAFIELD ENGINEERING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemring Energetics Uk Limited | 30 juin 2016 | Ardeer Site KA20 3LN Stevenston Troon House Ayrshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
LEAFIELD ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 30 juin 2003 Livré le 05 juil. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 19 mars 1990 Livré le 23 mars 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,050,000 from the company to the chargee | |
Brèves mentions All the assets and undertaking of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A credit agreement entitled "credit application" | Créé le 23 févr. 1990 Livré le 28 févr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company to close brothers limited under the terms of the credit application | |
Brèves mentions All rights, title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are detailed on the reverse of the form 395. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 21 déc. 1989 Livré le 03 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security which was presented for registration at the register of sasines on the 29/8/83 | Créé le 02 sept. 1983 Livré le 02 sept. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company under the terms of a personal band of even date. | |
Brèves mentions Lease by glenrothes development corporation in favour of leafields engineering limited (see doc M89 for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security which was presented for registration at the register of sasines on the 29/8/83. | Créé le 01 sept. 1983 Livré le 01 sept. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 9.587 acres or thereby at south field industrial estate kinglassie fife (see doc M88 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0