HMV CARD SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHMV CARD SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00635858
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HMV CARD SERVICES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HMV CARD SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HMV CARD SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HMV SHOPS LIMITED12 mai 198612 mai 1986
    RADIO RENTALS THAMESDOWN CABLE LIMITED17 juin 198317 juin 1983
    CLEARVISION,LIMITED27 août 195927 août 1959

    Quels sont les derniers comptes de HMV CARD SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 avr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour HMV CARD SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Ian Peter Kenyon en tant que directeur le 31 janv. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Trevor Philip Moore en tant que directeur le 08 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elaine Marriner en tant que directeur le 24 janv. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elaine Marriner en tant que secrétaire le 24 janv. 2013

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Ian Peter Kenyon en tant qu'administrateur le 03 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Trevor Philip Moore en tant qu'administrateur le 03 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Richard Fox en tant que directeur le 03 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 avr. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mai 2012

    État du capital au 11 mai 2012

    • Capital: GBP 85,570
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR le 13 mars 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Neil Bright en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 avr. 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Elaine Marriner le 10 mai 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Richard Fox le 10 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Elaine Marriner le 10 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Neil Irvine Bright le 10 mai 2010

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    13 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes pour une société dormante établis au 25 avr. 2009

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de HMV CARD SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Secrétaire
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Secrétaire
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    RITCHIE, Ian
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    British68246050001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Secrétaire
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Administrateur
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritish180993450001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Administrateur
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Administrateur
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001

    HMV CARD SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 mai 1998
    Livré le 04 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transactions
    • 04 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Créé le 14 mai 1998
    Livré le 15 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transactions
    • 15 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Emi Group PLC (As Security Trustee for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brèves mentions
    By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Swiss Bank Corporation as "Security Agent"Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Security Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of, and in Accordance with, the Senior Facility Agreement
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0