HMV CARD SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HMV CARD SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00635858 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HMV CARD SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Windsor House Spittal Street SL7 3HJ Marlow Buckinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HMV CARD SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 28 avr. 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour HMV CARD SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Peter Kenyon en tant que directeur le 31 janv. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Trevor Philip Moore en tant que directeur le 08 févr. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Elaine Marriner en tant que directeur le 24 janv. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Elaine Marriner en tant que secrétaire le 24 janv. 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Peter Kenyon en tant qu'administrateur le 03 sept. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Trevor Philip Moore en tant qu'administrateur le 03 sept. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Richard Fox en tant que directeur le 03 sept. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 avr. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR le 13 mars 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Bright en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 24 avr. 2010 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Elaine Marriner le 10 mai 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Richard Fox le 10 mai 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Elaine Marriner le 10 mai 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Neil Irvine Bright le 10 mai 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 13 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 25 avr. 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HMV CARD SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHT, Neil Irvine | Secrétaire | Pound End Cedar Drive, Cookham SL6 9DZ Maidenhead Berkshire | British | 180993450001 | ||||||
| CAMPBELL, Laurence James | Secrétaire | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Secrétaire | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Secrétaire | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | British | 76768320001 | ||||||
| MARRINER, Elaine | Secrétaire | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | British | 40470020001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Secrétaire | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SMITH, George Marsden | Secrétaire | 18 Bevin Square SW17 7BB London | British | 15729150003 | ||||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Secrétaire | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | British | 63502600001 | ||||||
| BELL, Duncan Charles | Administrateur | Longwood Queen Annes Road SL4 2BJ Windsor Berkshire | British | 9950440002 | ||||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Administrateur | Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead SL6 1SR Berkshire | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| FOX, Simon Richard | Administrateur | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||
| GILES, Alan James | Administrateur | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Administrateur | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| KENYON, Ian Peter | Administrateur | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 107735600001 | |||||
| LYMATH, Michael Gerald | Administrateur | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | England | British | 76768320001 | |||||
| MARRINER, Elaine | Administrateur | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 40470020001 | |||||
| MCALLISTER, Stuart | Administrateur | The Granary 38 Wellington Street OX9 3BN Thame Oxfordshire | British | 9406880001 | ||||||
| MOORE, Trevor Philip | Administrateur | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 113047410001 | |||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Administrateur | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 63502600001 |
HMV CARD SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 22 mai 1998 Livré le 04 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998) | Créé le 14 mai 1998 Livré le 15 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 mars 1998 Livré le 09 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 mars 1998 Livré le 09 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities | |
Brèves mentions By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0