TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED

TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00639535
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Siu Ping Lau le 10 sept. 2022

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    9 pagesAA

    Cessation de Coquet Shipping Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 août 2022

    1 pagesPSC07

    Notification de Kenwake Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 août 2022

    2 pagesPSC02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Junguang Xiao le 11 août 2022

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-company business 11/08/2022
    RES13

    État du capital au 23 août 2022

    • Capital: GBP 1.07498
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Mark Richard Banham en tant qu'administrateur le 01 janv. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Junguang Xiao en tant qu'administrateur le 01 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Chee Fun Lee en tant que directeur le 01 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Tuen Pei Pius Lam en tant que directeur le 01 mars 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Siu Ping Lau en tant qu'administrateur le 01 mars 2020

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OOCL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    Secrétaire
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    76693230001
    BANHAM, Mark Richard
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Administrateur
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    EnglandBritishAccountant57940780001
    LAU, Siu Ping
    One Harbour Square,181 Hoi Bun Road,Kwun Tong
    Kowloon
    15/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    Administrateur
    One Harbour Square,181 Hoi Bun Road,Kwun Tong
    Kowloon
    15/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    Hong KongChineseDirector268294940002
    XIAO, Junguang
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    Administrateur
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    ChinaChineseDirector277280010002
    MORRISON, William Stuart
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    British37064540002
    RUSSELL, Howard Neil
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    Secrétaire
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    British3000800001
    BANHAM, Mark Richard
    6 Mannington Close
    Rushmere St Andrew
    IP4 5PW Ipswich
    Administrateur
    6 Mannington Close
    Rushmere St Andrew
    IP4 5PW Ipswich
    EnglandBritishAccountant57940780001
    FUNG, Kit Man
    26d Tower 5-Rambler Crest
    1 Tsing Yi Road
    Tsing Yi
    Hong Kong
    Administrateur
    26d Tower 5-Rambler Crest
    1 Tsing Yi Road
    Tsing Yi
    Hong Kong
    ChineseAccountant76693040002
    HSIA, John Welfen
    23 Conduit Road
    FOREIGN Hong Kong
    Administrateur
    23 Conduit Road
    FOREIGN Hong Kong
    AmericanCompany Director32121220001
    LAM, Tuen Pei Pius
    181 Hoi Bun Road Kwun Tong
    Kowloon
    Hong Kong
    15/F One Harbour Square
    Hong Kong
    Administrateur
    181 Hoi Bun Road Kwun Tong
    Kowloon
    Hong Kong
    15/F One Harbour Square
    Hong Kong
    Hong KongAustralianGroup Financial Controller208569380001
    LEE, Chee Fun
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Administrateur
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Hong KongMalaysianGroup Legal Advisor76693610002
    MOK, Paul Yun Lee
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Administrateur
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    BritishGroup Financial Controller131049380001
    MORRISON, William Stuart
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritishChartered Accountant37064540002
    ROBINSON, Frank William
    33 Sebastian Avenue
    Shenfield
    CM15 8PW Brentwood
    Essex
    Administrateur
    33 Sebastian Avenue
    Shenfield
    CM15 8PW Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director2664580001
    RUSSELL, Howard Neil
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    Administrateur
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    BritishCompany Secretary3000800001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kenwake Ltd
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    England
    11 août 2022
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrement01473779
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Coquet Shipping Company Limited
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    Suffolk
    England
    06 avr. 2016
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    Suffolk
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited
    Autorité légaleEngland And Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of covenants
    Créé le 29 déc. 1983
    Livré le 04 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    All policies and contracts of insurance in respect of manchester challenge and her freights disbursments & projects (please see doc M72).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank International Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Ships mortgage
    Créé le 29 déc. 1983
    Livré le 04 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a loan agreements & a deed of covenant each dated 29.12.83
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the british flag vessel k/a: M.V. manchester challenge reg: at port of bristol with official no: 33746 and her boats & appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank International Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 31 juil. 1981
    Livré le 04 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from thecompany to the chargee secured by a charge dated 31/7/81 under the terms of a loan agreement dated 31/7/81 and the deed of covenants dated 31/7/81
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. daart america official no.337546 Registered at port of bristol all the insurances & earnings requisition compensations as effected in the deed of covenants.
    Personnes ayant droit
    • Midland Marine Bank N A.
    Transactions
    • 04 août 1981Enregistrement d'une charge
    Statutory ship mortgage
    Créé le 31 juil. 1981
    Livré le 04 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargee on any account current under the terms of a guarantee, the loan agreement and deed of covenants dated 31/7/81
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. dart america official no. 337546 port of registration bristol.
    Personnes ayant droit
    • Marine Midland Bank N.A.
    Transactions
    • 04 août 1981Enregistrement d'une charge
    Supplemental deed of covenant
    Créé le 19 mai 1981
    Livré le 03 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing £9,650,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee secured by a statutory mortgage dated 19/5/81 under the terms of a loan agreement and deed of covenant dated 15/no/79 amended by a loan agreement of even date.
    Brèves mentions
    The vessel "dart america" reg at port of bristol no 11 in 1970 official no 337546. earnings and requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • Marine Midland Bank N.A.
    Transactions
    • 03 juin 1981Enregistrement d'une charge
    Statutory mortgage
    Créé le 19 mai 1981
    Livré le 03 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargee on any accounts current under the terms of a loan agreement and deed of covenant both dated 15/10/79 amended by a loan agreement and deedof covenant of even date
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. "dart america" reg in port of bristol no: 11 in 1970 official no 337546.
    Personnes ayant droit
    • Marine Midland Bank LTD
    Transactions
    • 03 juin 1981Enregistrement d'une charge
    Deed of covenant
    Créé le 15 oct. 1979
    Livré le 30 oct. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by agreement dated 9/11/79 supplemental to a statutory mortgage 19/8/79
    Brèves mentions
    M.V. "dart america" british ship registered tynedale at port of bristol no.337546.the vessel all interests, rights,title and in tynedaleand to the insurances effected on the vessel and charterhire.
    Personnes ayant droit
    • Marine Midland Bank
    Transactions
    • 30 oct. 1979Enregistrement d'une charge
    Statutory ship mortgage
    Créé le 15 oct. 1979
    Livré le 23 oct. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an ac count current under the terms of a loan agreement and a deed of covenant both dated 15/10/79.
    Brèves mentions
    M.V. "dart america" registered at bristol with official no. 337546. (for full details see doc M65).
    Personnes ayant droit
    • Marine Midland Bank
    Transactions
    • 23 oct. 1979Enregistrement d'une charge
    Deed of covenant
    Créé le 11 nov. 1974
    Livré le 02 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Dated 11.12.74 further securing all monies due or to bec ome due secured by two other charges. Both dated 11.11.74 registered pursuant tosection 95 of companies act 1948 on 2.12.74.
    Brèves mentions
    A) all policies contracts of insuranace.
    Personnes ayant droit
    • Coquet Shipping Company LTD
    Transactions
    • 02 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory ship mortgage
    Créé le 11 nov. 1974
    Livré le 02 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due form the company to the chargee on an ac count current under terms of an agreement & deed of covenants both dated 11.11.74
    Brèves mentions
    The vessel "dart america".
    Personnes ayant droit
    • Coquet Shipping Company LTD
    Transactions
    • 02 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory ship mortgage
    Créé le 11 nov. 1974
    Livré le 02 déc. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under terms of an agreement & deed of covenants both dated 11/11/1974.
    Brèves mentions
    The vessel " atlantic phoenix".
    Personnes ayant droit
    • Coquet Shipping Company LTD
    Transactions
    • 02 déc. 1974Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Stat. Mortgage
    Créé le 08 nov. 1974
    Livré le 18 nov. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    35,681,887.98 french francs and all other monies due or to become due from the co. To the changee under the terms of a credit agreement dtd. 10.9.70 as amended & transferred and of a deed of covenant dtd 8.11.70
    Brèves mentions
    Sixty four sixty-fourth shares in mv atlantic phoenix.
    Personnes ayant droit
    • Banque Francaese Du Commerce Exterieur
    Transactions
    • 18 nov. 1974Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenants.
    Créé le 08 nov. 1974
    Livré le 18 nov. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    35,681,887.98 french francs and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreemnt dtd 10.9.70 asamended & transferred and secured by a charg dtd 8.11.74
    Brèves mentions
    The ship and all policies of insurance.
    Personnes ayant droit
    • Banque Francaese Du Commerce Exterieur
    Transactions
    • 18 nov. 1974Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 11 nov. 1971
    Livré le 12 nov. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £5,680,000 all other monies due etc. pursu ant to an agreement dated 23RD may 1969 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Monies payable to the company under a container chester dated 29TH june 1970.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1971Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of agreement
    Créé le 11 nov. 1971
    Livré le 12 nov. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing 5,680,000 and all other monies due or to become du e from the company to the chargee pursuant to the terms of a financial agreementdated 23RD may 1969 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    All the company rights title & interest in any monies payable to them under an agreement dated 11-11-71 under a further agreement of even date.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1971Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 11 nov. 1971
    Livré le 12 nov. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £5,680,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a financial agre ement dated 23RD may 1969 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    All the company rights title & interest in any monies payable to them under an agreement dated 11-11-71.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1971Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 11 nov. 1971
    Livré le 11 nov. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Deed of assignment securing £5,680,000 and all other monies due etc. pursuantto an any agreement dated 23RD may 1969 and dated supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Monies payable to the company under a container chester dated 29TH june 1970 and any further containers. See co 32 for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1971Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 30 nov. 1970
    Livré le 04 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,680,000 and all other moneys due pursuant to the terms of the financial agreement dated 23.5.69 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    For details of two sums of money deposited with the bank see doc (30).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Financial agreement
    Créé le 30 nov. 1970
    Livré le 04 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £5,680,000 and all other monies due et C. pursuant to the terms of the financial agreement dated 23RD may 1969 and deeds suppllemental thereto
    Brèves mentions
    The containers, supplied or to be supplied by swan hunter ship builders LTD. For "dart america".
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 30 nov. 1970
    Livré le 04 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £5,680,000 and all other monies due or to become due under the financial agreement, the mortgage the deed of covenant & the deed of assignment
    Brèves mentions
    All the companys right title & interest in any monies payable by dart containerline company LTD under a time charterparty dated 2.5.69 and addendum dated 4.11.70 and all other rights & benefits due to the company (for full details see doc 29).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 30 nov. 1970
    Livré le 04 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £5,680,000 and all other monies due etc. pursuant to the terms of a financial agreement dated 23RD may 1969, & change dated 30-11-70 & further securing all monies due or to become due to morgan grenfell & co LTD under the terms of a facility letter 14TH january 69 and another deed dated 23RD may 1969
    Brèves mentions
    The mortgaged premises being the ship, the containers, insurances, earnings of the ship & requisition, compensation as defined in the deed of covenant.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Ships mortgage
    Créé le 30 nov. 1970
    Livré le 04 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing all monies due or to become due on an account curr ent pursuant to a financial agreement dated 23-5-69 and a deed of covenant dated 30 november 1970 and another deed dated 23RD may 69
    Brèves mentions
    The motor vessel "deut america" official no 337546.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Financial agreement
    Créé le 23 mai 1969
    Livré le 29 mai 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,040,000 tog: with a commitment of 1% and all other monies due from theco.LTD to the bank pursuant to the terms of the agreement as well as all monies due to morgan grenfell & co. Under the terms of a facility letter dated 14/1/69 and another deed dated 23/3/63
    Brèves mentions
    (1) all the owners beneficial interest and all its benefits rights and titles in a building contract dated 30 july 1968 for the ship being built and known during construction as yard no 14 (the vessel) as she is constructed (2) all monies payable to the owner in respect of the insurance effected by the builder (see doc 26 for further details).
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Bank LTD
    Transactions
    • 29 mai 1969Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0