PS&N UK

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPS&N UK
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 00647900
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PS&N UK ?

    • (7487) /

    Où se situe PS&N UK ?

    Adresse du siège social
    Montpelier Galleries
    Montpelier Street
    SW7 1HH London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PS&N UK ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PHILLIPS SON & NEALE UK10 juin 199810 juin 1998
    PHILLIPS SON & NEALE25 janv. 196025 janv. 1960

    Quels sont les derniers comptes de PS&N UK ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour PS&N UK ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    12 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    11 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2002

    9 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2001

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de PS&N UK ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATSON, Christopher David
    7 Crescent Grove
    SW4 7AF London
    Secrétaire
    7 Crescent Grove
    SW4 7AF London
    British5629390001
    BROOKS, Robert
    12 Randolph Road
    W9 1AN London
    Administrateur
    12 Randolph Road
    W9 1AN London
    United KingdomBritish77117950001
    GOLDSTEIN, Julie Ann
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    Secrétaire
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    British102976800001
    MCMULLAN, David Malcom
    Brierley Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    Secrétaire
    Brierley Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    British36232820001
    MCNEILL, Victoria
    Flat 12 Transenna Works
    1 Laycock Street
    N1 1SJ London
    Secrétaire
    Flat 12 Transenna Works
    1 Laycock Street
    N1 1SJ London
    British85028640001
    PARSONS, John Malcolm
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    Secrétaire
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    British17177570001
    BENJAMIN, John Circus
    1 School Lane
    Weston Turville
    HP22 5SE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 School Lane
    Weston Turville
    HP22 5SE Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish79314780001
    BOYD, David
    38 Shelvers Way
    KT20 5QF Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    38 Shelvers Way
    KT20 5QF Tadworth
    Surrey
    British8200080001
    COWLEY, Michael Reuben
    63 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EF London
    Administrateur
    63 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EF London
    British31410780001
    CURNOW, Nicholas Ward
    24 Howard Place
    EH3 5JY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Howard Place
    EH3 5JY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish175720001
    FORTESCUE, Nicholas Cecil John
    8 Trouville Road
    SW4 8QL London
    Administrateur
    8 Trouville Road
    SW4 8QL London
    EnglandBritish79787070001
    GOLDSTEIN, Julie Ann
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    Administrateur
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    United KingdomBritish102976800001
    HAYCRAFT, John Bernard
    4 Kineton Cottages
    Little Kineton
    CV35 0DN Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    4 Kineton Cottages
    Little Kineton
    CV35 0DN Warwick
    Warwickshire
    British39888800001
    HOLLEST, Roger Henry
    The Old Malthouse
    Shaw
    SN12 8EF Melksham
    Wiltshire
    Administrateur
    The Old Malthouse
    Shaw
    SN12 8EF Melksham
    Wiltshire
    EnglandEnglish126255590001
    KINGSLEY, Victor George
    6 Mossfield Close
    CO3 3RG Colchester
    Essex
    Administrateur
    6 Mossfield Close
    CO3 3RG Colchester
    Essex
    British31410800001
    MADLEY, Richard John Benjamin
    Grassmead
    113 Beanacre
    SN12 7PT Melksham
    Wiltshire
    Administrateur
    Grassmead
    113 Beanacre
    SN12 7PT Melksham
    Wiltshire
    British17526390002
    MCMULLAN, David Malcom
    Brierley Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Brierley Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    EnglandBritish36232820001
    NEWALL, Archibald Patrick
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    Administrateur
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    British70430050001
    PARSONS, John Malcolm
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    Administrateur
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    British17177570001
    ROBERTS, Paul Simon
    Redhall Mill
    Katesmill Road
    EH14 1JF Edinburgh
    Administrateur
    Redhall Mill
    Katesmill Road
    EH14 1JF Edinburgh
    ScotlandBritish175740002
    SPARKS, Jeremy Charles
    Lake Cottage Furnace Lane
    Horsmonden
    TN12 8LZ Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Lake Cottage Furnace Lane
    Horsmonden
    TN12 8LZ Tonbridge
    Kent
    British36232870002
    THOMSON, Christopher Norman
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish11591540001
    WESTON, Christopher John
    5 Hillside Close
    Carlton Hill
    NW8 0EF London
    Administrateur
    5 Hillside Close
    Carlton Hill
    NW8 0EF London
    United KingdomBritish35351890001
    WESTON, William Jeremy
    201 Gilbert House
    Barbican Estate
    EC2Y 8BD London
    Administrateur
    201 Gilbert House
    Barbican Estate
    EC2Y 8BD London
    British56113340001

    PS&N UK a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of keyman life policy
    Créé le 14 juil. 1999
    Livré le 28 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life assured of william jeremy weston for £250,000 dated 27/4/98,policy no.a 12654649 t with all bonuses/benefits thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums assured and all bonuses and benefits under the policy on the life of roger henry hollest dated 20 february 1998 policy number a 12654650 y with norwich union life & pensions limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums assured and bonuses and benefits under the policy on the life of christopher norman thomson dated 26 february 1998 policy number a 12654651 u with norwich union life & pensions limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 févr. 1998
    Livré le 27 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 1988
    Livré le 19 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 13/4/88.
    Brèves mentions
    (See 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Cunadian Imperial Bank & Commerce
    Transactions
    • 19 avr. 1988Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0