LPH EQUIPMENT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LPH EQUIPMENT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00650762 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LPH EQUIPMENT LIMITED ?
Adresse du siège social | 125 Colmore Row B3 3SD Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LPH EQUIPMENT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour LPH EQUIPMENT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Norbert Dentressangle House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL le 08 mars 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tdg Headquarters Euroterminal Westinghouse Road Trafford Park Manchester M17 1PY le 28 sept. 2011 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tdg Directors No2 Limited en tant que directeur le 01 sept. 2011 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tdg Secretaries Limited en tant que secrétaire le 01 août 2011 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tdg Directors No1 Limited en tant que directeur le 01 sept. 2011 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de David Paul Lynch en tant qu'administrateur le 01 sept. 2011 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Lyndsay Navid Lane en tant que secrétaire le 01 août 2011 | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Gaultier De La Rochebrochard en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Tdg Directors No2 Limited le 16 mars 2011 | 2 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Tdg Directors No1 Limited le 16 mars 2011 | 2 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Tdg Secretaries Limited le 16 mars 2011 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rupert Nichols en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 17 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 18 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Rupert Henry Conquest Nichols en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 13 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LPH EQUIPMENT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVID LANE, Lyndsay | Secrétaire | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House United Kingdom | British | 163248340001 | ||||||||||
DE LA ROCHEBROCHARD D'AUZAY, Gaultier Marie Alain Xavier | Administrateur | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northmaptonshire Uk | France | French | Lawyer | 159274950001 | ||||||||
LYNCH, David Paul | Administrateur | Lodge Way NN5 7SL New Duston Norbert Dentressangle House Northampton United Kingdom | England | British | Accoutant | 52425370006 | ||||||||
COVENTRY, Neill Farquharson | Secrétaire | Penny Cottage 46 Green End Street Aston Clinton HP22 5JE Aylesbury Buckinghamshire | British | Finance Director | 39956810001 | |||||||||
KINLEY, John | Secrétaire | The Birches South Park TN13 1EL Sevenoaks Kent | British | Company Secretary | 9811620001 | |||||||||
LI, William | Secrétaire | Highwood Church Hill RH1 3BJ Merstham | British | 35818920001 | ||||||||||
PRICE, Alan Martin Andrew | Secrétaire | 30 Offington Gardens BN14 9AU Worthing West Sussex | British | 5634100001 | ||||||||||
TDG SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Euroterminal Westinghouse Road Trafford Park M17 1PY Manchester Tdg Headquarters United Kingdom |
| 54728830004 | ||||||||||
BRAY, Gilbert | Administrateur | 26 The Avenue KT10 0RY Claygate Surrey | United Kingdom | British | Director | 107094470001 | ||||||||
COLE, Alan Jack | Administrateur | Flat A 78 Charlwood Street SW1V 4PF London | British | Chief Executive | 9811630005 | |||||||||
COVENTRY, Neill Farquharson | Administrateur | Penny Cottage 46 Green End Street Aston Clinton HP22 5JE Aylesbury Buckinghamshire | British | Finance Director | 39956810001 | |||||||||
COX, Michael Alan | Administrateur | Cranbrook Hawks Hill KT22 9DS Leatherhead Surrey | England | British | Director | 1372270001 | ||||||||
JONES, Gordon | Administrateur | 5 The Paddocks Main Street DN5 7SQ Doncaster | British | Company Director | 28587100001 | |||||||||
KINLEY, John | Administrateur | The Birches South Park TN13 1EL Sevenoaks Kent | British | Company Secretary | 9811620001 | |||||||||
KINLEY, John | Administrateur | The Birches South Park TN13 1EL Sevenoaks Kent | British | Company Secretary | 9811620001 | |||||||||
LOCKTON, Frank Roy | Administrateur | 16 Sedgemoor Close BS48 4YR Nailsea North Somerset | British | Company Director | 92542880001 | |||||||||
MILLER, George William Leonard | Administrateur | The Gate House North Common Queens Road KT13 9DN Weybridge Surrey | British | Company Director | 36408020001 | |||||||||
NICHOLS, Rupert Henry Conquest | Administrateur | Westinghouse Road Trafford Park M17 1PY Manchester Tdg Headquarters Euroterminal | England | British | Company Secretary | 151889650001 | ||||||||
OLDFIELD, Colin Stuart | Administrateur | 14 North Park SE9 5AP London | United Kingdom | British | Director | 17018420001 | ||||||||
RYAN, Peter Michael | Administrateur | 26 Lowndes Avenue HP5 2HH Chesham Buckinghamshire | British | Company Director | 58252840001 | |||||||||
SMITH, James Robert | Administrateur | The White House 24 Ottways Lane KT21 2NZ Ashtead Surrey | British | Chartered Accountant | 45568320001 | |||||||||
TILBROOK, George William | Administrateur | Out Of Bounds 26 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LR Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Director | 10175180002 | |||||||||
TDG DIRECTORS NO1 LIMITED | Administrateur | Euroterminal Westinghouse Road Trafford Park M17 1PY Manchester Tdg Headquarters United Kingdom |
| 54728730006 | ||||||||||
TDG DIRECTORS NO2 LIMITED | Administrateur | Euroterminal Westinghouse Road Trafford Park M17 1PY Manchester Tdg Headquarters United Kingdom |
| 54728620005 |
LPH EQUIPMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Créé le 30 sept. 1992 Livré le 16 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the master facilities agreement dated 21/02/92 and this charge | |
Brèves mentions See form 395 ref M108L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 23 janv. 1992 Livré le 03 févr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as defined in this guarantee and debenture | |
Brèves mentions See doc ref M171 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
LPH EQUIPMENT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0