RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00652807 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 5 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS le 08 mai 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cemex House Coldharbour Lane Thorpe Egham Surrey TW20 8TD à No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 28 sept. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination de Vishal Puri en tant qu'administrateur le 29 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Larry Jose Zea Betancourt en tant que directeur le 29 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Larry Jose Zea Betancourt en tant qu'administrateur le 23 mars 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Leslie Collins en tant que directeur le 23 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital au 07 mars 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 1 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Daphne Margaret | Secrétaire | Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Cemex House Surrey | British | 77390020001 | ||||||
| PURI, Vishal | Administrateur | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 Berkshire | England | British | 209516530001 | |||||
| SMALLEY, Jason Alexander | Administrateur | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 Berkshire | England | British | 163491340001 | |||||
| BROWN, Charles Bennett | Secrétaire | Brendon Beenham RG7 5NX Reading Berkshire | British | 60016180002 | ||||||
| COLLINS, Michael Leslie | Secrétaire | 15 Sumner Close Fetcham KT22 9XF Leatherhead Surrey | British | 70461210001 | ||||||
| KALIA, Narinder Nath | Secrétaire | 51 Harewood Road TW7 5HN Isleworth Middlesex | British | 622020001 | ||||||
| STANDISH, Frank James | Secrétaire | 17 Fairmile House Twickenham Road TW11 8BA Teddington Middlesex | British | 62970090002 | ||||||
| WILLIAMS, David Brian | Secrétaire | 48 Victoria Road CF64 3HY Penarth Vale Of Glamorgan | British | 6237820001 | ||||||
| ALDRIDGE, Malcolm Robert | Administrateur | The Old Police House Peterston Super Ely CF5 6LH Cardiff Vale Of Glamorgan | British | 43555000001 | ||||||
| BARRACLOUGH, John David | Administrateur | 6 Dylan Close Llandough CF64 2PA Penarth South Glamorgan | British | 9871450001 | ||||||
| BARTLES-SMITH, Allan Rex | Administrateur | Beech Leaves 57 Ledborough Lane HP9 2DB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 36662560003 | ||||||
| BOTTLE, Stephen | Administrateur | 30 Alban Road SG6 2AT Letchworth Hertfordshire | British | 70897900001 | ||||||
| BROWN, Michael Mccoll | Administrateur | 7 Cliffside CF64 5RG Penarth South Glamorgan | British | 3814810001 | ||||||
| COLLINS, Michael Leslie | Administrateur | Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Cemex House Surrey | England | British | 70461210001 | |||||
| COOPER, John Brian | Administrateur | Waterside The Green Holyport SL6 2JT Maidenhead Berkshire | British | 7687060001 | ||||||
| DARWELL, Frederick Brian | Administrateur | Craig-Ny-Baa Knightwood Avenue SO43 7DQ Lyndhurst Hampshire | British | 60951560001 | ||||||
| GILLARD, Peter Henry | Administrateur | First Floor Flat 165 Fentiman Road, Vauxhall SW8 1JZ London | United Kingdom | British | 66091700004 | |||||
| HEPBURN, Graham George | Administrateur | Highfields Old House Farm Church Road WR7 4AT Crowle Worcester Worcestershire | British | 110030470001 | ||||||
| HEPBURN, Graham George | Administrateur | 5 Manor Close Prestwood HP16 0PT Great Missenden Buckinghamshire | British | 45136820001 | ||||||
| MILLARD, Richard Sydney | Administrateur | 24 Ridgeway Lisvane CF4 5RS Cardiff South Glamorgan | British | 27461030001 | ||||||
| NEAVE, David Sidney | Administrateur | The Grange Aston On Carrant GL20 8HL Tewkesbury Gloucestershire | British | 49553660005 | ||||||
| NEWSON, Edwyn Graham | Administrateur | 17 Durleston Park Drive Great Bookham KT23 4AJ Leatherhead Surrey | British | 56456160001 | ||||||
| ROBINSON, John Anthony | Administrateur | 14 Daws Lea HP11 1QF High Wycombe Buckinghamshire | British | 52745500001 | ||||||
| SAMUEL, Robert Henry, Mr | Administrateur | Highlands The Spinney Bassett SO16 7FW Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 27459640001 | |||||
| SMITH, Andrew Michael | Administrateur | Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Cemex House Surrey | United Kingdom | British | 112697170001 | |||||
| SWINSON, David Richard | Administrateur | Orchard House Tibberton WR9 7NJ Droitwich Worcestershire | British | 11081110001 | ||||||
| WILLIAMS, David Brian | Administrateur | 48 Victoria Road CF64 3HY Penarth Vale Of Glamorgan | British | 6237820001 | ||||||
| WILLIAMS, David Brian | Administrateur | 48 Victoria Road CF64 3HY Penarth Vale Of Glamorgan | British | 6237820001 | ||||||
| ZEA BETANCOURT, Larry Jose | Administrateur | Cemex House Coldharbour Lane Thorpe TW20 8TD Egham Surrey | England | Venezuelan | 132043870002 |
RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Shipowners agreement | Créé le 27 nov. 1986 Livré le 09 déc. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed. | |
Brèves mentions (A) any money payable under the terms of the financial agreement dated 27.11.86 (b) the vessel presently being constructed for the company by appledone ferguson shipbuilders limited known during the construction as no as 143. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Financial agreement | Créé le 27 nov. 1986 Livré le 09 déc. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the currant dated 17.7.86 | |
Brèves mentions All the company's beneficial interest all its benefits rights and titles in an under the contract including the versel as she is constructed and all her machinery. Equipment and materials (see 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mai 1980 Livré le 23 mai 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property known as garnsen wharf kingston upon hull, north humberside.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mai 1980 Livré le 23 mai 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property at avondale road, cardiff, south glamorgan.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
RMC AGGREGATES (SOUTH WALES) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0