BRITTON POLYIAN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRITTON POLYIAN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00654622
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POLYIAN LIMITED30 mars 196030 mars 1960

    Quels sont les derniers comptes de BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Coveris Flexibles Uk Holland Park Wardentree Park Pinchbeck Lincolnshire PE11 3ZN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Holland Place Wardentree Park Pinchbeck Spalding Lincolnshire PE11 3ZN England à Coveris Flexibles Uk Holland Park Wardentree Park Pinchbeck Lincolnshire PE11 3ZN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Holland Place Wardentree Park Pinchbeck Spalding Lincolnshire PE11 3ZN England à 1 More London Place London SE1 2AF le 18 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 juin 2019

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Sarah Gooding en tant que directeur le 30 juin 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gary Edward Rehwinkel en tant que directeur le 14 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian Collins en tant que directeur le 08 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    Nomination de Mr Andreas Heigl en tant qu'administrateur le 31 août 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Duane Owens en tant que directeur le 28 août 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Mike Alger en tant que directeur le 01 mai 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Brian Collins en tant qu'administrateur le 03 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Gary Edward Rehwinkel en tant qu'administrateur le 31 mai 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Edward Lapping en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jonathan Pallas en tant qu'administrateur le 31 mars 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Karl Robert Bostock en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEIGL, Andreas
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    England
    AustriaAustrianGroup Treasurer250017750001
    PALLAS, Jonathan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishDirector150181140001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    BritishFinancial Controller94622690001
    BRUTON, Paul Howard
    126 Berkeley Avenue
    HP5 2RT Chesham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    126 Berkeley Avenue
    HP5 2RT Chesham
    Buckinghamshire
    British35532290001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director42598360003
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    BritishAccountant78877930001
    RICHARDSON, Lee
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    Secrétaire
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    British177380590001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Secrétaire
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    British73033280001
    WHITEHAIR, Colin Roy Keith
    352 Reigate Road
    KT17 3LY Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    352 Reigate Road
    KT17 3LY Epsom
    Surrey
    British3042720001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ALGER, Mike
    c/o Britton Taco Limited
    Winsford
    CW7 3RD Cheshire
    Road One Industrial Estate
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Britton Taco Limited
    Winsford
    CW7 3RD Cheshire
    Road One Industrial Estate
    England
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector193141670001
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    Administrateur
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    BritishCompany Director28376970001
    BEAUMONT, Nigel Peter
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishExecutive95868800001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Administrateur
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    EnglandBritishGroup Controller94622690001
    BOSTOCK, Karl Robert
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director188188900001
    BURNHAM, Jedidiah James
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    AmericanExecutive56560680001
    CLARK, Michael
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Administrateur
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector92294570002
    COLLINS, Brian John
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    EnglandBritishFinance Director270699960001
    CONSTANCIO, Gail Ann
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    AmericanExecutive55754050001
    DEAN, Darren William
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director114199420001
    FISHER, David Robert
    4 Greenmead
    South Woodham Ferrers
    CM3 5NL Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    4 Greenmead
    South Woodham Ferrers
    CM3 5NL Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director3042730001
    FORDHAM, Royston Alfred Frances
    26 Long Meadow
    Hutton
    CM13 2HJ Brentwood
    Essex
    Administrateur
    26 Long Meadow
    Hutton
    CM13 2HJ Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director47108100001
    FORDHAM, Stuart David Michael
    Yew Tree House Hillwood Grove
    Hutton Mount
    CM13 2PD Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Yew Tree House Hillwood Grove
    Hutton Mount
    CM13 2PD Brentwood
    Essex
    BritishFinancial Manager28448700003
    GOODING, Sarah
    c/o Britton Taco Limited
    Winsford
    CW7 3RD Cheshire
    Road One Industrial Estate
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Britton Taco Limited
    Winsford
    CW7 3RD Cheshire
    Road One Industrial Estate
    England
    United Kingdom
    London, EnglandUnited KingdomDirector193141080001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritishCompany Director42598360003
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    UkBritishAccountant78877930001
    LAPPING, Mark Edward
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director188189180001
    MILLICAN, Keith
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    Administrateur
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    BritishExecutive59839640001
    OWENS, Duane
    c/o Britton Taco Limited
    Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Road One
    Cheshire England
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Britton Taco Limited
    Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Road One
    Cheshire England
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector193551550001
    PARISH, Beth Anne
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    UsaExecutive55754140001
    PETERS, Raymond Albert
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishExecutive70111470001
    REHWINKEL, Gary Edward
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Administrateur
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United StatesAmericanDirector232783670001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Administrateur
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    EnglandBritishGroup Executive Chairman73033280001
    SELINSKE, Steven
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    Administrateur
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    AmericanExecutive Vice President57338010001
    SISSON, Jill Bartlett Woodman
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    AmericanGeneral Counsel56560720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRITTON POLYIAN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Marc Leder
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    06 avr. 2016
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Non
    Nationalité: American
    Pays de résidence: United States
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Rodger Krouse
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    06 avr. 2016
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Non
    Nationalité: American
    Pays de résidence: United States
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    BRITTON POLYIAN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 mai 2004
    Livré le 27 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 mai 2004
    Livré le 27 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the holders of the ever 2284 limited variable rate loan notes 2013 (the noteholders) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 27 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A guarantee and debenture made between the companies listed on the shedule attached to the form 395 (together the "charging companies"), the chargee and the cvc entities named therein
    Créé le 02 nov. 2001
    Livré le 19 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Each of the charging companies has covenanted and guaranteed that it will on demand in writing made to it by the noteholders in accordance with the terms of the loan note instrument pay to the subordinated security agent for the account of each of the beneficiaries all moneys obligations and liabilities which shall for the time being be due from owing or incurred by it or by any other group company (including any other company) to each of the noteholders under the loan note instrument and whether on or after such demand whether actually or contingently whether solely or jointly with any other person whether as principal or surety and whether or not the relevant beneficiary was an original party to the relevant transaction including all interest commission fees charges costs and expenses which each beneficiary may in the course of its business charge or incur in respect of any company or its affairs and so that interest shall be computed and compounded in accordance with the loan note instrument (after as well as before any demand or judgment)
    Brèves mentions
    Properties as listed on the schedule attached to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Subordinated Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transactions
    • 19 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 20 avr. 1998
    Livré le 06 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston,as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 06 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 17 juil. 1992
    Livré le 20 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 new amplas model 1050-s serial no.9.9206 (See form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 20 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 oct. 1986
    Livré le 07 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed charge on all book and other debts owing to the company floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 23 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 avr. 1980
    Livré le 15 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H units 17,19, 21,21A, 23, 23A and 25A, grainger road industrial estate, southend on sea, essex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 15 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BRITTON POLYIAN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 mars 2020Dissolved on
    19 juin 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0