KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED

KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00658852
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHEMRING EOD LIMITED21 août 200821 août 2008
    SEGMATIC LIMITED11 mai 196011 mai 1960

    Quels sont les derniers comptes de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 juil. 2019

    • Capital: GBP 1.10
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 08/07/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Gregory Lewis en tant qu'administrateur le 19 janv. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 03 janv. 2017

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Steven John Bowers en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 2,300
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael James Flowers le 13 mars 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2015

    État du capital au 02 janv. 2015

    • Capital: GBP 2,300
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2013

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Michael James Flowers en tant qu'administrateur le 24 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secrétaire
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secrétaire
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Administrateur
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Administrateur
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    United KingdomBritish42841660001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Administrateur
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    MORRIS, Keith Hedley
    17 Hill Hayes Lane
    Hullavington
    SN14 6EB Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    17 Hill Hayes Lane
    Hullavington
    SN14 6EB Chippenham
    Wiltshire
    British6212480001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 juin 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2244623
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 11 oct. 1993
    Livré le 13 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 18/12/89
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 oct. 1990
    Livré le 05 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land and buildings at pigeon house lane, stratton street, swindon, wiltshire. Title no. Wt 64373; and a fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 05 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 déc. 1989
    Livré le 08 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from kembrey group limited and from the company under the terms of the charge to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H land & buildings lying to north west of pigeon house lane stratton st margaret swindon wilts.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 18 déc. 1989
    Livré le 02 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 août 1988
    Livré le 23 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from kembrey group limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge to the chargee
    Brèves mentions
    Land at pigeon house lane, stratton st. Margaret, swindon, wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 15 juil. 1988
    Livré le 21 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book and other debts. Floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 févr. 1987
    Livré le 05 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from kembrey industries limited or any of its subsidiaries. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land at pigeon house lane, stratton, st.margaret, swindon, wiltshire and all other the f/h & l/h properties.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Caisse Nationale De Credit Argicole.
    Transactions
    • 05 mars 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 18 nov. 1982
    Livré le 30 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & factory premises at priory road kenilworth.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 19 oct. 1982
    Livré le 09 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts. Floating charge over (see doc. M55).. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0