INSTRON HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INSTRON HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00662120 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INSTRON HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 5 Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INSTRON HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour INSTRON HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Itw International Holdings Llc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Ryan Ronald Dale en tant que secrétaire le 18 déc. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Rowell le 16 mars 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Matthew Deakin en tant que directeur le 30 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Ufland en tant que directeur le 13 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 20 déc. 2016
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Stephen James Rowell en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 99 Gresham Street Fifth Floor London EC2V 7NG United Kingdom à 5 Aldermanbury Square 13th Floor London EC2V 7HR | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de INSTRON HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALE, Ryan Ronald | Secrétaire | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 | 241475040001 | |||||||||||
| S & J REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England |
| 43122090005 | ||||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Administrateur | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| ROWELL, Stephen James | Administrateur | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 | United Kingdom | British | 208316380001 | |||||||||
| ATKIN, Jane Margaret | Secrétaire | Hope Cottage 20 Townside Haddenham HP17 8BG Aylesbury Buckinghamshire | British | 29170840002 | ||||||||||
| WEBB, Stephen Martin | Secrétaire | 2 Strawberry Close Prestwood HP16 0SG Great Missenden Buckinghamshire | British | 18623430001 | ||||||||||
| WEBB, Stephen Martin | Secrétaire | 2 Strawberry Close Prestwood HP16 0SG Great Missenden Buckinghamshire | British | 18623430001 | ||||||||||
| ALLENBY SMITH, Norman Laing | Administrateur | The Oak House Iwerne Minster DT11 8NF Blandford Forum Dorset | British | 50784750002 | ||||||||||
| AMARAL, Joseph Ernest | Administrateur | 150 Absalona Hill Road Chepachet Rhode Island 02814 Usa | American | 79407220001 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Administrateur | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| BAXTER, Adam | Administrateur | Lime Tree Cottage West Street SL7 2BY Marlow Buckinghamshire | British | 61835810001 | ||||||||||
| BUCHANAN, Malcolm Read | Administrateur | Lockgate Cottage Lockgate Road, Sidlesham Common PO20 7QH Chichester West Sussex | British | 19323660006 | ||||||||||
| BURR, George Sterling | Administrateur | 2 Trailside Road FOREIGN Weston Mass 02193 Usa | American | 18623450001 | ||||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Administrateur | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 146225080003 | |||||||||
| HINDMAN, Harold | Administrateur | 300 Dudley Street FOREIGN Brookline Mass 02146 Usa | American | 18623460001 | ||||||||||
| JARDINE, Christopher Douglas | Administrateur | Pound House 65 Updown Hill GU20 6DW Windlesham Surrey | British | 1860370001 | ||||||||||
| KEARINS, John Gerrard | Administrateur | 58 Culver Road AL1 4ED St Albans Hertfordshire | British | 19323670001 | ||||||||||
| LOHR, Raymond David | Administrateur | Stratton Cottage The Square, Lone Crewdon HP18 9AA Aylesbury Buckinghamshire | British | 81990960001 | ||||||||||
| MACGREGOR, Ian Malcolm | Administrateur | Shepherds Close Shepherds Green Rotherfield Greys RG9 4QR Henley On Thames Oxfordshire | British | 1860320003 | ||||||||||
| MARTINDALE, Steven Leo | Administrateur | 149 Summer Street Norwell Massachussetts 02061 Usa | American | 81807810001 | ||||||||||
| MCCONNELL, James Michael | Administrateur | 8 Pine Hill Drive Needham Ma 02192 Usa | American | 51047820001 | ||||||||||
| MOULDING, Linton Alan | Administrateur | 18 Parker Street Cambridge Ma 02138 Usa | British | 51047850001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Administrateur | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Administrateur | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | England | British | 161583570001 | |||||||||
| VERE, Philip | Administrateur | Walnut Lodge Carters Lane HP18 9DE Long Crendon Buckinghamshire | England | British | 167275090001 | |||||||||
| WEBB, Stephen Martin | Administrateur | 2 Strawberry Close Prestwood HP16 0SG Great Missenden Buckinghamshire | British | 18623430001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INSTRON HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itw International Holdings Llc | 06 avr. 2016 | West Lake Avenue Glenview 3600 Illinois 60026 United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
INSTRON HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Syndicated debenture | Créé le 24 mai 2004 Livré le 09 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any UK credit party to UK agent, UK security trustee or any UK lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Property, investments, debts, intellectual property, licences, goodwill & uncalled capital, policies and proceeds thereof, fixed plant machinery and equipment, chattels floating charge undertaking and all property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Third party charge of shares | Créé le 29 sept. 1999 Livré le 13 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from instron limited to the secured beneficiaries or any of them under the loan documents (as defined in the finance agreement) and to the security trustee under the charge and on any account whatsoever | |
Brèves mentions 6,600,000 shares of £1 each in instron limited and all monies and benefits etc arising thereunder by way of bonus option etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0