ROACH FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROACH FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00663499
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROACH FOODS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ROACH FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Seton House
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROACH FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORMAN C.ROACH & SON LIMITED28 juin 196028 juin 1960

    Quels sont les derniers comptes de ROACH FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ROACH FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Andrew Michael James Cracknell en tant que directeur le 05 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Morten Schott Knudsen en tant qu'administrateur le 20 mars 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Michael James Cracknell en tant qu'administrateur le 15 févr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Tommy Bro Moelgaard en tant que directeur le 15 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Stephen Ronald William Francis en tant que directeur le 05 juin 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Tommy Bro Moelgaard en tant qu'administrateur le 05 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helen Margaret Glennie en tant que directeur le 05 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    5 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 nov. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium a/c be cancelled 19/10/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Christopher Malcolm Terry en tant que secrétaire le 29 juin 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Helen Margaret Glennie en tant qu'administrateur le 29 juin 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Stephen Ronald William Francis en tant qu'administrateur le 29 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Malcolm Terry en tant que directeur le 29 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Thomas en tant que directeur le 29 juin 2017

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2016 au 31 mars 2017

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de ROACH FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KNUDSEN, Morten Schott
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    DenmarkDanishChief Financial Officer256823310001
    COOTE, John Roy
    Ruddles, The Boatyard
    Portmellon
    PL26 6PN Mevagissey
    Cornwall
    Secrétaire
    Ruddles, The Boatyard
    Portmellon
    PL26 6PN Mevagissey
    Cornwall
    British77551290001
    JENSEN, Herluf
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    DanishGroup Director96281690001
    TERRY, Christopher Malcolm
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Secrétaire
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    206512230001
    TREMBATH, David John
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    Secrétaire
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    British68807490001
    AMBLER, Anthony Spencer
    Green Rigg
    Rooking
    CA11 0NP Patterdale
    Cumbria
    Administrateur
    Green Rigg
    Rooking
    CA11 0NP Patterdale
    Cumbria
    United KingdomBritishCompany Director18296040007
    BULLOCK, Geoffrey Thomas
    86 Berrybrook Meadow
    Exminster
    EX6 8UA Exeter
    Devon
    Administrateur
    86 Berrybrook Meadow
    Exminster
    EX6 8UA Exeter
    Devon
    BritishRegional Sales Director72510840001
    CARTMELL, Barrie Maxwell
    The Manor
    Lower Carblake, Cardinham
    PL30 4BX Bodmin
    Cornwall
    Administrateur
    The Manor
    Lower Carblake, Cardinham
    PL30 4BX Bodmin
    Cornwall
    United KingdomBritishDirector70916120002
    COOTE, John Roy
    Ruddles, The Boatyard
    Portmellon
    PL26 6PN Mevagissey
    Cornwall
    Administrateur
    Ruddles, The Boatyard
    Portmellon
    PL26 6PN Mevagissey
    Cornwall
    BritishAccountant77551290001
    CRACKNELL, Andrew Michael James
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United KingdomBritishCeo Senior Vice President251560410001
    ENEVOLDSEN, Flemming Nyenstad
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    DenmarkDanishCeo156168570001
    FINNEY, Peter Stamatis
    Feltham Farm
    Corfe
    TA3 7DD Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Feltham Farm
    Corfe
    TA3 7DD Taunton
    Somerset
    BritishOperations Director64150300002
    FORBES, Mark St John Graham
    May House
    Burlawn Wadebridge
    PL27 7LD Plymouth
    Cornwall
    Administrateur
    May House
    Burlawn Wadebridge
    PL27 7LD Plymouth
    Cornwall
    BritishManaging Director124790560001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritishDirector205102630001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritishDirector234600990001
    HAZZARD, Gerald Anthony
    69 Killyvarder Way
    PL25 3DL St Austell
    Cornwall
    Administrateur
    69 Killyvarder Way
    PL25 3DL St Austell
    Cornwall
    BritishDirector28554660001
    JAKOBSEN, Carsten Svejgaard
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandDanishDirector165874230001
    JENSEN, Herluf
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandDanishDirector96281690001
    JOHNS, Christopher Allan
    Little Prideaux Farm Annex
    St Blazey Par
    PL24 2SS Cornwall
    Administrateur
    Little Prideaux Farm Annex
    St Blazey Par
    PL24 2SS Cornwall
    BritishOperations Director37093620001
    JOHNSON, Richard
    Hope Barn
    St. Ewe
    PL26 6EU St. Austell
    Cornwall
    Administrateur
    Hope Barn
    St. Ewe
    PL26 6EU St. Austell
    Cornwall
    BritishPurchasing Director70802450001
    LEACH, Bernard Dennis
    1 Deeble Close
    PL7 4BR Plymouth
    Devon
    Administrateur
    1 Deeble Close
    PL7 4BR Plymouth
    Devon
    EnglandBritishBuyer28554700001
    MOELGAARD, Tommy Bro
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    NetherlandsDanishCfo243186630001
    MURRELLS, Steven Geoffrey
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo156162510001
    PAWSON, Robin
    Batcombe Road
    Leigh
    DT9 6JA Sherborne
    Bridge Cottage
    Dorset
    Administrateur
    Batcombe Road
    Leigh
    DT9 6JA Sherborne
    Bridge Cottage
    Dorset
    United KingdomBritishDirector126017100002
    RICKARD, Nigel Peter
    No5 Penworth Close
    PL15 9TG Launceston
    Cornwall
    Administrateur
    No5 Penworth Close
    PL15 9TG Launceston
    Cornwall
    United KingdomBritishCompany Director78344910001
    ROACH, Charles Graham
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    EnglandEnglishDirector11070150001
    ROBERTS, Alban Edwin
    Evenlode 4 North Hill Park
    PL25 4BJ St Austell
    Cornwall
    Administrateur
    Evenlode 4 North Hill Park
    PL25 4BJ St Austell
    Cornwall
    BritishDirector28554690001
    TERRY, Christopher Malcolm, Mr.
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    EnglandBritishChartered Accountant60746700002
    THOMAS, Christopher
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo63844650001
    TREMBATH, David John
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    Administrateur
    Cherry Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NJ Saltash
    Cornwall
    EnglandBritishFinance Director68807490001
    WEIR, Andrew
    37 Polstain Road
    Threemilestone
    TR3 6DB Truro
    Cornwall
    Administrateur
    37 Polstain Road
    Threemilestone
    TR3 6DB Truro
    Cornwall
    BritishProduction Director (Redruth)52652960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROACH FOODS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Tulip Limited
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    England
    06 avr. 2016
    Warwick Technology Park, Gallows Hill
    CV34 6DA Warwick
    Seton House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement608077
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ROACH FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Trading as Rabobank International,Londonbranch,as Security Agent
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge
    Créé le 30 mai 2001
    Livré le 04 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a composite guarantee and debenture dated 10 september 1999
    Brèves mentions
    The f/h property k/a plots 6 and 7 pennygillam industrial estate launceston cornwall t/n CL43500 and l/h land at newport industrial estate launceston cornwall.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A letter of assignment
    Créé le 16 mars 2001
    Livré le 27 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, obligations and liabilities at any time due, owing or incurred by the company to the royal bank of scotland PLC as agent and security trustee and the other secured parties (each as defined in a composite guarantee and debenture dated 10 september 1999) or any of them, including without limitation, all moneys, obligations and liabilities due, owing or incurred under or pursuant to (a) the secured documents, namely (1) a facilities agreement dated 10 september 1999 (2) an ancillary facilities letter dated 10 september 1999 (3) any agreements made in respect of hedging arrangements in accordance with the facilities agreement; and (4) a subordination deed dated 10 september 1999; (b) the guarantees and indemnities given by the company under the debenture (c) all other provisions of the debenture
    Brèves mentions
    With full title guarantee assigned absolutely to the chargee all its rights, titles benefits and interests whatsoever, whether present or future, proprietary, contractual or otherwise under or arising out of or evidenced by the sale and purchase agreement dated 16 march 2001 and made between amongst others, the company as seller and brake bros food limited PLC as buyer and the sale and purchase agreement dated 16 march 2001 made between amongst others the company as buyer and brake bros food limited PLC as seller in each case as from time to time varied, extended or replaced, including without limitation, all claims for damages or other remedies in respect of any breach or inaccuracy in either of the sale and purchase agreements and the benefit of, and the right to make any claim in respect of all, warranties, indemnities and representations given to the company in either of the sale and purchase agreements.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 27 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 sept. 1999
    Livré le 22 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred under or pursuant to: (a) the following documents (together, and each as it may from time to time be amended, varied, novated, supplemented or replaced, the "secured documents"), namely: (I) a facilities agreement dated 10TH september 1999; (ii) an ancillary facilities letter dated 10TH september 1999; (iii) any agreements made in respect of hedging arrangements in accordance with the facilities agreement; and (iv) a subordination deed dated 10TH september 1999; (b) the guarantees and indemnities given by the company under the debenture, which secure all the obligations under the secured documents of each of flagship foods limited (the "primary borrower"), dalehead foods holdings limited and dalehead foods limited and each other subsidiary of the primary borrower which becomes a party to the debenture; and (c) all other provisions of the debenture
    Brèves mentions
    First fixed charges over all of the present and future assets including land, plant, machinery and equipment, goodwill and uncalled capital, debts and calims, stocks, shares, bonds and other securities of any kind.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Plcon Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Parties to the Secured Documents
    Transactions
    • 22 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 oct. 1995
    Livré le 20 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22,338 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First fixed charge over: 1 x volkswagen golf l diesel 1.9 reg no: N28 hrl, chassis no: LHSW382083. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 20 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 août 1995
    Livré le 15 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)
    Transactions
    • 15 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 05 juin 1995
    Livré le 06 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £122,400.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the goods detailed in the attached schedule 1X hpc plusair rotary screw air compressor hpc model BS61 serial no 143923. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 06 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 05 juin 1995
    Livré le 06 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £61,560 and all other sums due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed charge over:- 1* 1995 citroen zx 19D dimension,registration no:M74DCV ....................1.9D.........................:M354 crl various other vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 06 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 1995
    Livré le 03 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £305,600 and all other sums due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The items as listed with all books,manuals,handbooks,drawings and other documents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 03 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 08 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £321,671 and all other sums due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One automatic gripper and one automatic bacon slicing,weighing and packing line supplied by dipl-ing schindler & wagner kg; invoice/no.473.26 Dated 25/2/94 and invoice/no.982.80 Dated 21/9/94.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 08 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 oct. 1994
    Livré le 20 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels and plant machinery or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 20 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 nov. 1993
    Livré le 03 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Two new mercedes-benz 1838LS commercial vehicles reg no : L945 uaf, chassis 6555332KO15410, reg no L949 uaf chassis no : 6555332KO16810.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 03 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 07 oct. 1993
    Livré le 11 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One new automatic bacon slicing packing line scv 26/614/300-02/03-mag-abs-ro/re-c, serial no 00180.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 11 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 28 juin 1993
    Livré le 30 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £115,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over : 3 x mercedes benz 1314, 3.64M w/b 12,000 kg gvw and 3 x insulated and refrigerated bodies with carrier vatna 400H refrigeration units. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 30 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 17 juin 1993
    Livré le 21 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 21 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 nov. 1989
    Livré le 15 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at wilson way pool redruth cornwall. Comprising parts of ordnance survey nos. 2839 2780 & 2779. t/n cl 48605. proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 25 août 1982
    Livré le 07 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the company's f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 1980
    Livré le 08 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at ebenezer in the parish of luxulyan cornwall comprising nos 928,1008,1009 on the os map containing altogether 5.298 acres or thereabouts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 mars 1976
    Livré le 02 avr. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H factory premises at ebenezer, cornwall. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1976Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 avr. 1975
    Livré le 17 avr. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future goodwill including uncalled capital. By way of fixed & floating charge. (See doc 29).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 1975Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0