LAKE SPRING WATER CO. LIMITED

LAKE SPRING WATER CO. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLAKE SPRING WATER CO. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00669922
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERNARD MATTHEWS (WESTON) LIMITED13 sept. 196013 sept. 1960

    Quels sont les derniers comptes de LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Robert Burnett en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Zaliha Williamson en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que secrétaire le 18 août 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juin 2016

    État du capital au 20 juin 2016

    • Capital: GBP 3,526,736
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David John Joll en tant que directeur le 06 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2015

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 3,526,736
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 juin 2014

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Michael Reger en tant que directeur le 03 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert Burnett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2014

    État du capital au 05 juin 2014

    • Capital: GBP 3,526,736
    SH01

    Nomination de Mrs Zaliha Williamson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Simpson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    2 pagesAA

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 4

    2 pagesMR05

    Cessation de la nomination de Noel Bartram en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr David John Joll en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Michael Reger en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Yvonne Goldingham en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 juil. 2012

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Reger en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, John Granger
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    British11486660001
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Secrétaire
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    172133500001
    REGER, David Michael
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Secrétaire
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    BritishCompany Secretary151343430001
    BARTRAM, Noel Frederick
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishDirector37442010003
    BROWN, John Granger
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Rose Cottage
    32 West End Old Costessey
    NR8 5AG Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishChartered Accountant11486660001
    BURNETT, Robert
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    ScotlandBritishGroup Ceo86190250002
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    United KingdomBritishDirector170465830001
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    United KingdomBritishDirector170465830001
    HARRISON, Neil Charles
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant111081410001
    JOLL, David John
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    United KingdomBritishDirector178372710001
    JOLL, David John
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    Administrateur
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    United KingdomBritishManaging Director178372710001
    MATTHEWS, Bernard Trevor
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director10918210001
    REGER, David Michael
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishDirector151343430001
    REGER, David Michael
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishCompany Secretary151343430001
    SIMPSON, Andrew John
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishDirector105165150001
    WILLIAMSON, Zaliha
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    Norwich
    NR9 5QD Norfolk
    EnglandBritishDirector323983980001

    LAKE SPRING WATER CO. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of amendment and accession
    Créé le 20 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of debenture
    Créé le 11 juin 2007
    Livré le 21 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 21 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2013L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 15 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • De Lage Landen Ireland Company
    Transactions
    • 15 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 05 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to any finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The Agent)
    Transactions
    • 05 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0