LAKE SPRING WATER CO. LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LAKE SPRING WATER CO. LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00669922 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?
Adresse du siège social | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Burnett en tant que directeur le 31 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Zaliha Williamson en tant que directeur le 31 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que secrétaire le 18 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Joll en tant que directeur le 06 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2015 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 juin 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Michael Reger en tant que directeur le 03 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Burnett en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Zaliha Williamson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Simpson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013 | 2 pages | AA | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 4 | 2 pages | MR05 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Noel Bartram en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr David John Joll en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Michael Reger en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Yvonne Goldingham en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 juil. 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Reger en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LAKE SPRING WATER CO. LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, John Granger | Secrétaire | Rose Cottage 32 West End Old Costessey NR8 5AG Norwich Norfolk | British | 11486660001 | ||||||
GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Secrétaire | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | 172133500001 | |||||||
REGER, David Michael | Secrétaire | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | British | Company Secretary | 151343430001 | |||||
BARTRAM, Noel Frederick | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Director | 37442010003 | ||||
BROWN, John Granger | Administrateur | Rose Cottage 32 West End Old Costessey NR8 5AG Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 11486660001 | ||||
BURNETT, Robert | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | Scotland | British | Group Ceo | 86190250002 | ||||
GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | United Kingdom | British | Director | 170465830001 | ||||
GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | United Kingdom | British | Director | 170465830001 | ||||
HARRISON, Neil Charles | Administrateur | Bramley House The Loke Cringleford NR4 6XA Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Accountant | 111081410001 | ||||
JOLL, David John | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | United Kingdom | British | Director | 178372710001 | ||||
JOLL, David John | Administrateur | Irmingland Hall Corpusty NR11 6QF Holt Norfolk | United Kingdom | British | Managing Director | 178372710001 | ||||
MATTHEWS, Bernard Trevor | Administrateur | Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Company Director | 10918210001 | ||||
REGER, David Michael | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Director | 151343430001 | ||||
REGER, David Michael | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Company Secretary | 151343430001 | ||||
SIMPSON, Andrew John | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Director | 105165150001 | ||||
WILLIAMSON, Zaliha | Administrateur | Great Witchingham Hall Norwich NR9 5QD Norfolk | England | British | Director | 323983980001 |
LAKE SPRING WATER CO. LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and accession | Créé le 20 janv. 2011 Livré le 03 févr. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of debenture | Créé le 11 juin 2007 Livré le 21 juin 2007 | En cours | Montant garanti The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 déc. 2006 Livré le 15 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security agreement | Créé le 05 déc. 2006 Livré le 08 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A security agreement | Créé le 28 févr. 2001 Livré le 05 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of the obligors to any finance party under each finance document (all terms as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0