PETERBORO' WEB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPETERBORO' WEB LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00674979
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PETERBORO' WEB LIMITED ?

    • impression de journaux (18110) / Industries manufacturières

    Où se situe PETERBORO' WEB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY City Of London
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PETERBORO' WEB LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour PETERBORO' WEB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    10 pagesLIQ14

    Cessation de la nomination de David John King en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Guy Butterworth en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Michael Mccall en tant que secrétaire le 31 déc. 2019

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG à 6 Snow Hill City of London London EC1A 2AY le 08 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 18 mars 2019

    LRESEX

    Nomination de Mr Michael Guy Butterworth en tant qu'administrateur le 24 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Ashley Gilroy Mark Highfield en tant que directeur le 05 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 août 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Parkinson en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2015

    État du capital au 06 août 2015

    • Capital: GBP 100
    • Capital: USD 1
    SH01

    Nomination de Mr Richard Parkinson en tant qu'administrateur le 01 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Graham Crow en tant que directeur le 31 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 03 janv. 2015

    10 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2013

    11 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ashley Gilroy Mark Highfield le 01 juil. 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de PETERBORO' WEB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COOPER, Gillian
    22 Guntons Road
    Newborough
    PE6 7QW Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    22 Guntons Road
    Newborough
    PE6 7QW Peterborough
    Cambridgeshire
    British71857190001
    KNIGHT, Mark
    19 Heron Walk
    PE15 9HU March
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    19 Heron Walk
    PE15 9HU March
    Cambridgeshire
    British63953510001
    MCCALL, Peter Michael
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    161463650001
    RAY, Mark John
    Rycroft School Road
    Broughton
    PE28 3AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Rycroft School Road
    Broughton
    PE28 3AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    British51635450001
    SMITH, David Paul
    Printworks, Oundle Road
    Woodston
    PE2 9QH Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Printworks, Oundle Road
    Woodston
    PE2 9QH Peterborough
    Cambridgeshire
    British39237320003
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    Secrétaire
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    British16754910001
    BAILLIE, John Andrew Main
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    BritishAccountant76483990001
    BANHAM, Melvyn
    28 Chestnut Way
    Market Deeping
    PE6 8LP Peterborough
    Lincolnshire
    Administrateur
    28 Chestnut Way
    Market Deeping
    PE6 8LP Peterborough
    Lincolnshire
    BritishPrinter53668860001
    BANHAM, Melvyn
    28 Chestnut Way
    Market Deeping
    PE6 8LP Peterborough
    Lincolnshire
    Administrateur
    28 Chestnut Way
    Market Deeping
    PE6 8LP Peterborough
    Lincolnshire
    BritishCompany Director53668860001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Administrateur
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritishNewspaper Director37521870002
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritishChartered Accountant76600500002
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Administrateur
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritishFinancial Director474360001
    CROW, David Graham
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishManaging Director56466300004
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Administrateur
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritishCeo136914890001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Executive Officer164400440001
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    Administrateur
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    BritishCompany Director328390001
    KING, David John
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer179020430001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Administrateur
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer159877110001
    NUNES CARVALHO, Nicholas John
    Greystones
    Tansor
    PE8 5HS Peterborough
    Administrateur
    Greystones
    Tansor
    PE8 5HS Peterborough
    BritishPrinter14500710001
    PARKINSON, Richard
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritishManaging Director103967630001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director64281400001
    RAY, Mark John
    Rycroft School Road
    Broughton
    PE28 3AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Rycroft School Road
    Broughton
    PE28 3AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant51635450001
    ROBINSON, John
    Huntsman House
    365 Thorpe Road Longthorne
    PE3 6NA Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Huntsman House
    365 Thorpe Road Longthorne
    PE3 6NA Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishDirector Of Companies15651850002
    STRONG, Peter Michael
    268 Unthank Road
    NR2 2AJ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    268 Unthank Road
    NR2 2AJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishPubli52045300002
    WENMAN, John William
    2 Ravensdale
    Stilton
    PE7 3XN Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    2 Ravensdale
    Stilton
    PE7 3XN Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishManaging Director15653410001
    WENMAN, John William
    2 Ravensdale
    Stilton
    PE7 3XN Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    2 Ravensdale
    Stilton
    PE7 3XN Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishManaging Director15653410001
    WINFREY, Richard John
    2 Church Lane
    Sibbington
    PE8 6LP Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    2 Church Lane
    Sibbington
    PE8 6LP Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishDirector Of Companie14439750001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PETERBORO' WEB LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Johnston Press Plc
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    06 avr. 2016
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc015382
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PETERBORO' WEB LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2014
    Livré le 01 juil. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transactions
    • 01 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of accession
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 30 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Parties
    Transactions
    • 30 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 juil. 1996
    Livré le 19 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(For Itself and as Trustee for and on Behalf Ofthe Agent, the Banks and Rbs)
    Transactions
    • 19 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 05 janv. 1966
    Livré le 05 janv. 1966
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing debenture stock of east midland allied press limited amounting to £500,00
    Brèves mentions
    Flaoting charge undertaking and assets pesent and future including unclled capital. (See doc 20).
    Personnes ayant droit
    • Industrial Insurance Co. LTD
    Transactions
    • 05 janv. 1966Enregistrement d'une charge
    • 15 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PETERBORO' WEB LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mars 2019Commencement of winding up
    17 avr. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Edward Butt
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    practitioner
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    practitioner
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0