CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00676215 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Drayton Hall Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex England England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rachel Nancye Amey en tant que directeur le 08 mars 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB le 14 mars 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 3 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom le 04 oct. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Christopher Francis Judd en tant que secrétaire le 23 mai 2012 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Philip Gorman en tant que secrétaire le 23 mai 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Jeremy Philip Gorman en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucy Turner en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rachel Nancye Carr le 01 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cape House 3 Red Hall Avenue Paragon Business Village Wakefield West Yorkshire WF1 2UL le 01 déc. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 1 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Lucy Finch Turner le 23 déc. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rachel Nancye Carr le 18 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Victoria Anne George le 18 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 1 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDD, Christopher Francis | Secrétaire | Millenia Tower One Temasek Avenue 039192 Singapore #09-03 Singapore | 169530870001 | |||||||
| GEORGE, Victoria Anne | Administrateur | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 134024500001 | |||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Secrétaire | 4 Hill Top LS29 9RS Ilkley West Yorkshire | British | 82905830002 | ||||||
| GORMAN, Jeremy Philip | Secrétaire | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | 160675560001 | |||||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Secrétaire | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 829660002 | ||||||
| RHODES, Jeremy | Secrétaire | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||
| SMITH, Stephen Harry | Secrétaire | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||
| TURNER, Lucy Finch | Secrétaire | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Secrétaire | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | 99402260002 | ||||||
| AMEY, Rachel Nancye | Administrateur | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 133976650005 | |||||
| BINGHAM, Richard Keith | Administrateur | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | 131046090001 | ||||||
| CARTWRIGHT, Paul Ian | Administrateur | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | 40873830002 | ||||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Administrateur | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | 82905830001 | ||||||
| GILLESPIE, Andrew James | Administrateur | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | England | British | 89560440001 | |||||
| JACKSON, Francis Keith John | Administrateur | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | 15469790001 | |||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Administrateur | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 829660002 | |||||
| SMITH, Stephen Harry | Administrateur | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Administrateur | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | 99402260002 | |||||
| WIDDOWSON, Ian Richard | Administrateur | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 16941000001 | ||||||
| CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Créé le 20 juil. 2001 Livré le 26 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined) | |
Brèves mentions Freehold properties, (I) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Second supplemental trust deed | Créé le 28 avr. 1987 Livré le 07 mai 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti Securing £3,458,818 10% debenture stock 1986/91 of cape industries public limited company and all other moneys due or to become due pursuant to this deed. | |
Brèves mentions And all patents see doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Single debenture | Créé le 30 janv. 1985 Livré le 14 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 1) f/h & l/h property of the company. 2). all stocks shares bonds and securities. 3) all book & other debts 4). the uncalled capital goodwill and all patents, patent applications trade marks etc. 5) undertaking and all other property assets and rights. (For full details see doc. M. 96). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1985 Livré le 05 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as trustee for itself and other banks named therein. On any account whatsoever. | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental trust deed. | Créé le 01 avr. 1968 Livré le 10 avr. 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti Debenture stock of the cape asbestos company LTD amounting to £2,600,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed 12/9/66. | |
Brèves mentions First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock,. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 12 sept. 1966 Livré le 21 sept. 1966 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2,000,000 debenture stock of the cape asbestos company LTD | |
Brèves mentions First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock,. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Eq. Charge | Créé le 26 juil. 1966 Livré le 16 août 1966 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2,000,000 debenture stock of the cape asbestos company LTD | |
Brèves mentions First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0